CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE ET DE DEVELOPPEMENT D'EQUIPEMENTS PUBLICS - CRIDEP -

Address:
1000 Rue De La Maurie, Blainville, QC J7C 3B5

CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE ET DE DEVELOPPEMENT D'EQUIPEMENTS PUBLICS - CRIDEP - is a business entity registered at Corporations Canada, with entity identifier is 1816683. The registration start date is December 18, 1984. The current status is Dissolved.

Corporation Overview

Corporation ID 1816683
Corporation Name CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE ET DE DEVELOPPEMENT D'EQUIPEMENTS PUBLICS - CRIDEP -
Registered Office Address 1000 Rue De La Maurie
Blainville
QC J7C 3B5
Incorporation Date 1984-12-18
Dissolution Date 2015-04-13
Corporation Status Dissolved / Dissoute
Number of Directors 3 - 3

Directors

Director Name Director Address
JACQUES BRAULT 22 EST RUE SHERBROOKE, APT. 2, MONTREAL QC H2X 1C2, Canada
JEAN H. MASSEY 6786 CHRISTOPHE COLOMB, MONTREAL QC H2S 2H2, Canada
PAUL MERCIER 9 CARRE CHAMPLAIN, BLAINVILLE QC J7C 1E5, Canada

Corporation History

Type Effective Date Expiry Date Detail
Act 1984-12-18 current Canada Corporations Act - Part II (CCA - Part II)
Loi sur les corporations canadiennes - partie II (LCC - Partie II)
Act 1984-12-17 1984-12-18 Canada Corporations Act - Part II (CCA - Part II)
Loi sur les corporations canadiennes - partie II (LCC - Partie II)
Address 1984-12-18 current 1000 Rue De La Maurie, Blainville, QC J7C 3B5
Name 1984-12-18 current CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE ET DE DEVELOPPEMENT D'EQUIPEMENTS PUBLICS - CRIDEP -
Status 2015-04-13 current Dissolved / Dissoute
Status 2014-11-14 2015-04-13 Active - Dissolution Pending (Non-compliance) / Actif - Dissolution en cours (Non-conformité)
Status 2004-12-16 2014-11-14 Active / Actif
Status 2004-12-16 2004-12-16 Active - Dissolution Pending (Non-compliance) / Actif - Dissolution en cours (Non-conformité)
Status 1984-12-18 2004-12-16 Active / Actif

Activities

Date Activity Details
2015-04-13 Dissolution Section: 222
1984-12-18 Incorporation / Constitution en société

Office Location

Address 1000 RUE DE LA MAURIE
City BLAINVILLE
Province QC
Postal Code J7C 3B5
Country Canada

Corporations in the same postal prefix

Corporation Name Office Address Incorporation
Les Importations Watera Inc. 103-100, Rue Gaston-dumoulin, Blainville, QC J7C 0A3 2020-06-30
Novatis Imports Inc. 100, Gaston-dumoulin, Suite 103, Blainville, QC J7C 0A3 2017-05-01
9093532 Canada Inc. 100, Gaston-dumoulin, Bureau 103, Blainville, QC J7C 0A3 2014-11-20
The Gaspe Fly Co. Inc. 80 Gaston-dumoulin, Unit 103, Blainville, QC J7C 0A3 2012-04-10
7933762 Canada Inc. 60, Rue Gaston-dumoulin, Blainville, QC J7C 0A3 2011-08-03
Mecanertech Inc. 80, Gaston-dumoulin, Bureau 106, Blainville, QC J7C 0A3 1998-03-30
R. Nicar Broker Inc. 10, Rue Gaston-dumoulin, Suite 500, Blainville, QC J7C 0A3 1992-04-09
Spi SantÉ SÉcuritÉ Inc. 60 Rue Gaston-dumoulin, Blainville, QC J7C 0A3
Equipements De Securite Et Premiers Soins Global Inc. 60, Rue Gaston-dumoulin, Blainville, QC J7C 0A3 1993-11-25
Instavolt Inc. 10, Rue Gaston-dumoulin, Bureau 500, Blaiville, QC J7C 0A3 2009-01-05
Find all corporations in postal code J7C

Corporation Directors

Name Address
JACQUES BRAULT 22 EST RUE SHERBROOKE, APT. 2, MONTREAL QC H2X 1C2, Canada
JEAN H. MASSEY 6786 CHRISTOPHE COLOMB, MONTREAL QC H2S 2H2, Canada
PAUL MERCIER 9 CARRE CHAMPLAIN, BLAINVILLE QC J7C 1E5, Canada

Entities with the same directors

Name Director Name Director Address
PLANORDICO INC. JACQUES BRAULT 128, chemin de la Grande-Côte, #502, Saint-Eustache QC J7P 1A7, Canada
PLANORDICO INC. JACQUES BRAULT 32 LES CHENES, LAVAL SUR LE LAC QC H7R 1H2, Canada
LA SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTION QUADRA INC. JACQUES BRAULT 32 RUE LES CHENES, LAVAL SUR LE LAC QC H7R 1H2, Canada
147630 CANADA INC. JACQUES BRAULT 149 GRANDE COTE, ST-EUSTACHE QC J7P 1A9, Canada
151804 CANADA INC. JACQUES BRAULT 32 LES CHENES, LAVAL-SUR-LE-LAC QC H7R 1H2, Canada
3786102 CANADA INC. JACQUES BRAULT 128, chemin de la Grande-Côte, #502, ST-EUSTACHE QC J7P 1A7, Canada
139554 CANADA INC. JACQUES BRAULT 149 GRANDE COTE, ST-EUSTACHE QC , Canada
RECYCLAGE HUILEX INC. JACQUES BRAULT 34 RUE AUTHIER, GRANBY QC , Canada
3473724 CANADA INC. PAUL MERCIER 471 VERSANT DU RUISSEAU, PREVOST QC J0R 1T0, Canada
3316785 CANADA INC. PAUL MERCIER 122 ALSTON ROAD, POINTE CLAIRE QC H9R 3E4, Canada

Competitor

Search similar business entities

City BLAINVILLE
Post Code J7C 3B5

Similar businesses

Corporation Name Office Address Incorporation
Bon Centre Research & Development Inc. 445 Av. Thorncrest, Dorval, QC H9S 2X9 2020-03-31
Centre De Recherche Et De Developpement En Maconnerie 4528 6a Street North East, Suite 105, Calgary, AB T2E 4B2 1982-01-11
Centre De Recherche Et De Développement Melville Inc. 500 Rue D'avaugour, Bureau 2050, Boucherville, QC J4B 0G6
Centre De DÉveloppement Et De Recherche En Intelligence NumÉrique (cdrin) 608 Ave St-redempteur, Matane, QC G4W 0E1 2007-09-06
Centre De Recherche Sur La DÉmocratie Pour Le DÉveloppement En Afrique (cerddaf) 97-3 Ritchie, Ottawa, ON K2B 6E8 1999-08-19
Centre De Recherche Et De Developpement Prothetique C.r.d.p. Ltee 8415 St-denis, Suite 305, Montreal, QC H2P 2H1 1983-10-31
Le Centre De Recherche Appliquée Et Au Développement Multimédia (creadem) Inc. 2297 Pierre Bernard, Montreal, QC H1L 4P6 1996-10-30
Centre De Recherche Sur Les Politiques Sociales Et Le Développement écomomique 1161 Bélanger Avenue, Suite 208, Ottawa, ON K1H 1A6 2014-07-29
Centre for Research & Development In Interpretation & Translation (credit) 340 Avenue Bernatchez, Québec, QC G1M 2A6 2020-04-28
Centre De Recherche Et Développement Expérimental En Informatique Libre (credil) F3018-283 Alexandre Tache, Gatineau, QC J9A 1L8 2009-05-12

Improve Information

Please provide details on CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE ET DE DEVELOPPEMENT D'EQUIPEMENTS PUBLICS - CRIDEP - by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Corporations Canada
Jurisdiction Canada
Website www.ic.gc.ca
Entity Count 846524

Trending Searches