GROUPE CADORET, ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC.

Address:
619 Ave Brochu, Sept-iles, QC G4R 2X7

GROUPE CADORET, ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC. is a business entity registered at Corporations Canada, with entity identifier is 2646188. The registration start date is September 24, 1990. The current status is Active.

Corporation Overview

Corporation ID 2646188
Business Number 897336962
Corporation Name GROUPE CADORET, ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC.
Registered Office Address 619 Ave Brochu
Sept-iles
QC G4R 2X7
Incorporation Date 1990-09-24
Corporation Status Active / Actif
Number of Directors 1 - 10

Directors

Director Name Director Address
GENEVIÈVE MICHAUD 658, rue de la Rive, Sept-Îles QC G4R 0C8, Canada
STEVE MALTAIS 194, ave. Gamache, Sept-Iles QC G4R 2H2, Canada
MARCEL CADORET 1521, DU MOYAC, BAIE COMEAU QC G5C 3G8, Canada

Corporation History

Type Effective Date Expiry Date Detail
Act 1990-09-24 current Canada Business Corporations Act (CBCA)
Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA)
Act 1990-09-23 1990-09-24 Canada Business Corporations Act (CBCA)
Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA)
Address 2016-09-30 current 619 Ave Brochu, Sept-iles, QC G4R 2X7
Address 1990-09-24 2016-09-30 522 Rue Brochu, Sept-iles, QC G4R 2X3
Name 2007-12-13 current GROUPE CADORET, ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC.
Name 1995-07-18 2007-12-13 SERVICES GEOTECHNARP INC.
Name 1990-09-24 1995-07-18 174881 CANADA INC.
Status 1995-03-07 current Active / Actif
Status 1995-01-01 1995-03-07 Active - Dissolution Pending (Non-compliance) / Actif - Dissolution en cours (Non-conformité)

Activities

Date Activity Details
2016-11-02 Amendment / Modification Section: 178
2007-12-13 Amendment / Modification Name Changed.
2007-10-12 Amendment / Modification
2003-12-22 Amendment / Modification
1990-09-24 Incorporation / Constitution en société

Annual Returns Filings

Year Annual Meeting Date Corporation Type
2019 2019-06-30 Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders
Société n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins
2018 2017-06-30 Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders
Société n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins
2017 2016-06-30 Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders
Société n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins

Office Location

Address 619 AVE BROCHU
City SEPT-ILES
Province QC
Postal Code G4R 2X7
Country Canada

Corporations in the same postal prefix

Corporation Name Office Address Incorporation
10529478 Canada Inc. 22, Rue Des Marais, Sept-Îles, QC G4R 0C2 2017-12-07
Transport De Gravier Daniel Fournier Ltee 94, Rue Saint-jean, Rivière-du-loup, QC G4R 0C2 1979-02-05
Synase Corporation 662 De La Rive, Sept-iles, QC G4R 0C8 2005-02-14
119028 Canada Inc. 30, Rue Holliday, Sept-iles, QC G4R 0G9
146157 Canada Inc. 997, Rue De La Rive, Sept Iles, QC G4R 0L4 1985-06-14
Gestion Lionel Bouchard Inc. 18 Bourdages, Sept Iles, QC G4R 1A8 1980-07-07
Immeubles Michel Robichaud Inc. 97 Rue Holliday, Sept-iles, QC G4R 1E9 1979-08-09
Vitrerie Norcristal (1982) Inc. 360 Perreault, Sept-iles, QC G4R 1K3 1982-03-16
7178468 Canada Inc. 454, Avenue Perreault, Sept-Îles, QC G4R 1K5 2009-06-01
6976182 Canada Inc. 454 Rue Perreault, Sept-Îles, QC G4R 1K5 2008-05-14
Find all corporations in postal code G4R

Corporation Directors

Name Address
GENEVIÈVE MICHAUD 658, rue de la Rive, Sept-Îles QC G4R 0C8, Canada
STEVE MALTAIS 194, ave. Gamache, Sept-Iles QC G4R 2H2, Canada
MARCEL CADORET 1521, DU MOYAC, BAIE COMEAU QC G5C 3G8, Canada

Entities with the same directors

Name Director Name Director Address
9252215 CANADA INC. Geneviève Michaud 658, rue de la Rive, Sept-Îles QC G4R 0C8, Canada
6645518 CANADA INC. MARCEL CADORET 1521, RUE DU MOYAC, BAIE-COMEAU QC G5C 3G8, Canada
9252215 CANADA INC. Marcel Cadoret 1521, rue du Moyac, Baie-Comeau QC G5C 3G8, Canada
9252215 CANADA INC. Steve Maltais 194, avenue Gamache, Sept-Îles QC G4R 2H2, Canada

Competitor

Search similar business entities

City SEPT-ILES
Post Code G4R 2X7

Similar businesses

Corporation Name Office Address Incorporation
Groupe Handfield, Arpenteurs-géomètres Inc. 49 Chemin De Montréal Est, Gatineau, QC J8M 1K3 2010-02-09
Perron, Hudon, BÉlanger Arpenteurs-gÉomÈtres Inc. 85, Chemin De La Grande-côte, Boisbriand, QC J7G 1C4
GÉoposition Arpenteurs-gÉomÈtres Inc. 450, 3e Avenue, Bureau 105, Val-d'or, QC J9P 1S2
GÉoposition Arpenteurs-gÉomÈtres Inc. 450, 3e Avenue, Bureau 105, Val-d'or, QC J9P 1S2
Legault Trudeau, Arpenteurs-gÉomÈtres Inc. 430 Chicoine, Dorion, QC J7V 7E4 1980-12-19
Gauthier Et Vincent Arpenteurs-géomètres Inc. 320, Route 323, Montebello, QC J0V 1L0 2011-02-02
Descarreaux-dubÉ & AssociÉs Arpenteurs-gÉomÈtres Inc. 633, 2Ème Avenue, Val-d'or, QC J9P 1W5 2009-04-01
Houle, Arpenteurs-gÉomÈtres Inc. 172, Rue Lanthier, Sainte-anne-de-bellevue, QC H9X 4A3 2018-11-26
Nadeau, Fournier Arpenteurs-gÉomÈtres Inc. 428 Notre Dame, Gatineau, QC J8P 1L8 1996-09-19
Arguin Et Associés, Arpenteurs-géomètres Inc. 455 Rue Du Marais, Bureau 150, Québec, QC G1M 3A2 2010-02-05

Improve Information

Please provide details on GROUPE CADORET, ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC. by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Corporations Canada
Jurisdiction Canada
Website www.ic.gc.ca
Entity Count 846524

Trending Searches