ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS ET RÉDACTEURS DE L'AGROALIMENTAIRE (ACRA)

Address:
130, Chemin Du Versant, Rigaud, QC J0P 1P0

ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS ET RÉDACTEURS DE L'AGROALIMENTAIRE (ACRA) is a business entity registered at Corporations Canada, with entity identifier is 310247. The registration start date is March 19, 1957. The current status is Active.

Corporation Overview

Corporation ID 310247
Business Number 829978279
Corporation Name ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS ET RÉDACTEURS DE L'AGROALIMENTAIRE (ACRA)
Registered Office Address 130, Chemin Du Versant
Rigaud
QC J0P 1P0
Incorporation Date 1957-03-19
Corporation Status Active / Actif
Number of Directors 10 - 10

Directors

Director Name Director Address
Isabelle Petit 555, boul. Roland-Therrien, Longueuil QC J4H 3Y9, Canada
Marie-Hélène Gaudin 9001 Boulevard de l'Acadie, Montréal QC H4N 3H7, Canada
RACHEL BRILLANT 888, RUE ST-JEAN, QUEBEC QC G1K 9L4, Canada
CLAUDIA GEMME 9001 BOULEVARD DE L'ACADIE, BUREAU 200, MONTREAL QC H4N 3H7, Canada
Julie Desbiens 555 Boulevard Roland-Therrien, Longueuil QC J4H 3V6, Canada
MELANIE LAGACE 555 BOULEVARD ROLAND-THERRIEN, BUREAU 535, LONGUEUIL QC J4H 4E7, Canada
Luc Gagnon 130, chemin du Versant, Rigaud QC J0P 1P0, Canada
Natalie Pouliot 905, rue du Marché central, Montréal QC H4N 1K2, Canada
MARIE-HELENE CLICHE 9001, BOULEVARD DE L'ACADIE, BUREAU 200, MONTREAL QC H4N 3H7, Canada
EVA LAROUCHE 1655 BOULEVARD ALPHONSE-DESJARDINS, BUREAU 180, MONTREAL QC G6V 0B7, Canada
CLAUDE LAMBERT 2845, RUE DES BOULEAUX, SAINTE-ADELE QC J8B 1K6, Canada

Corporation History

Type Effective Date Expiry Date Detail
Act 2014-06-19 current Canada Not-for-profit Corporations Act (NFP Act)
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL)
Act 1957-03-19 2014-06-19 Canada Corporations Act - Part II (CCA - Part II)
Loi sur les corporations canadiennes - partie II (LCC - Partie II)
Act 1957-03-18 1957-03-19 Canada Corporations Act - Part II (CCA - Part II)
Loi sur les corporations canadiennes - partie II (LCC - Partie II)
Address 2017-08-08 current 130, Chemin Du Versant, Rigaud, QC J0P 1P0
Address 2014-06-19 2017-08-08 3406, Avenue Du Mont-royal Est, Montreal, QC H1X 3K3
Address 2013-05-23 2014-06-19 3406 Avenue Du Mont Royal Est, Montreal, QC H1X 3K3
Address 2007-10-12 2013-05-23 3940 Nicolet, St-hyacinthe, QC J2S 7H1
Address 1957-03-19 2007-10-12 3940 Nicolet, St-hyacinthe, QC J2S 7H1
Name 2014-06-19 current ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS ET RÉDACTEURS DE L'AGROALIMENTAIRE (ACRA)
Name 2005-05-04 2014-06-19 Association des communicateurs et rédacteurs de l'agroalimentaire ACRA
Name 1957-03-19 2005-05-04 ASSOCIATION CANADIENNE DES REDACTEURS AGRICOLES DE LANGUE FRANCAISE (A.C.R.A.L.F.)
Status 2014-06-19 current Active / Actif
Status 1957-03-19 2014-06-19 Active / Actif

Activities

Date Activity Details
2014-06-19 Continuance (transition) / Prorogation (transition) Jurisdiction: Canada Corporations Act - Part II (CCA-II) / Loi sur les corporations canadiennes, partie 2 (LCC-Partie 2)
2007-09-11 Ordinary By-Laws Filing / Dépôt de règlement ordinaire
2005-05-04 Amendment / Modification Name Changed.
1957-03-19 Incorporation / Constitution en société

Annual Returns Filings

Year Annual Meeting Date Corporation Type
2019 2018-11-14 Non-Soliciting
N'ayant pas recours à la sollicitation
2018 2017-09-30 Non-Soliciting
N'ayant pas recours à la sollicitation
2017 2016-10-07 Non-Soliciting
N'ayant pas recours à la sollicitation

Office Location

Address 130, chemin du versant
City Rigaud
Province QC
Postal Code J0P 1P0
Country Canada

Corporations in the same location

Corporation Name Office Address Incorporation
Association Canadienne D'agri-marketing (québec) 130, Chemin Du Versant, Rigaud, QC J0P 1P0 2003-08-26

Corporations in the same postal code

Corporation Name Office Address Incorporation
Arouba Marco Design Inc. 209,201, Lot416, Rigaud, QC J0P 1P0 2020-08-12
Cernunnos Farms Ltd. 415 Chemin De La Montagne, Rigaud, QC J0P 1P0 2020-07-20
Alt F4 Inc. 257 Chemin De L'anse, Rigaud, QC J0P 1P0 2020-05-27
Lalonde Capital Immobilier Inc. 214 Chemin J René-gauthier, Rigaud, QC J0P 1P0 2019-11-29
Simply Comfy Living Inc. 47 Chemin Du Hudson Club, Rigaud, QC J0P 1P0 2019-08-05
Vertical 7 Inc. 24 Rue De La Coopérative, Rigaud, QC J0P 1P0 2019-04-18
11320319 Canada Inc. 752 Rue Daniel, Rigaud, QC J0P 1P0 2019-03-26
Jomijean Tsi Inc. 330, Chemin Émile Nelligan, Rigaud, QC J0P 1P0 2018-08-23
Bebaby Ltd. 45 Saint-antoine, Rigaud, QC J0P 1P0 2018-07-26
Close Out Canada M.e.s. Inc. 877 Rue Des Merles, TrÈs St-rÉdempteur, QC J0P 1P0 2018-06-19
Find all corporations in postal code J0P 1P0

Corporation Directors

Name Address
Isabelle Petit 555, boul. Roland-Therrien, Longueuil QC J4H 3Y9, Canada
Marie-Hélène Gaudin 9001 Boulevard de l'Acadie, Montréal QC H4N 3H7, Canada
RACHEL BRILLANT 888, RUE ST-JEAN, QUEBEC QC G1K 9L4, Canada
CLAUDIA GEMME 9001 BOULEVARD DE L'ACADIE, BUREAU 200, MONTREAL QC H4N 3H7, Canada
Julie Desbiens 555 Boulevard Roland-Therrien, Longueuil QC J4H 3V6, Canada
MELANIE LAGACE 555 BOULEVARD ROLAND-THERRIEN, BUREAU 535, LONGUEUIL QC J4H 4E7, Canada
Luc Gagnon 130, chemin du Versant, Rigaud QC J0P 1P0, Canada
Natalie Pouliot 905, rue du Marché central, Montréal QC H4N 1K2, Canada
MARIE-HELENE CLICHE 9001, BOULEVARD DE L'ACADIE, BUREAU 200, MONTREAL QC H4N 3H7, Canada
EVA LAROUCHE 1655 BOULEVARD ALPHONSE-DESJARDINS, BUREAU 180, MONTREAL QC G6V 0B7, Canada
CLAUDE LAMBERT 2845, RUE DES BOULEAUX, SAINTE-ADELE QC J8B 1K6, Canada

Entities with the same directors

Name Director Name Director Address
XCOTECHMA CONSULTANTS INC. Claude Lambert 2530 rue du Grand-Degré, Sainte-Julie QC J3E 0B5, Canada
ALSTOM Hydro Canada Inc. CLAUDE LAMBERT 1350 ST. ROCH ROAD, SOREL-TRACY QC J3R 5P9, Canada
IMMEUBLES ANNECY LTEE CLAUDE LAMBERT 250 BONAIR ST-FRANCOIS, LAVAL QC , Canada
CUISI-DESIGN DALBERT LTEE CLAUDE LAMBERT 7010 LACROIX, MONTREAL QC , Canada
B.H.L. ELECTRIQUE INC. CLAUDE LAMBERT 27 CARRE DE VIMY, LEVIS QC G6V 2K9, Canada
IMMEUBLES RICHEMOND LTEE CLAUDE LAMBERT 250 RUE BON AIR, ST FRANCOIS QC , Canada
MÉCANIKA CONSTRUCTION INC. CLAUDE LAMBERT 1350 ST. ROCH ROAD, SOREL-TRACY QC J3R 5P9, Canada
LES RENOVATIONS CLAUDE LAMBERT ET FILS LTEE CLAUDE LAMBERT 7010 RUE LACROIX, MONTREAL QC , Canada
LES GESTIONS CLAUDE LAMBERT INC. CLAUDE LAMBERT 7010 RUE LACROIX, MONTREAL QC , Canada
BioChem ImmunoSystèmes Canada Inc. · BioChem ImmunoSystems Canada Inc. CLAUDE LAMBERT 140 RUE LAPIERRE, ST-LAURENT QC H7N 2J8, Canada

Competitor

Search similar business entities

City Rigaud
Post Code J0P 1P0

Similar businesses

Corporation Name Office Address Incorporation
Acra Concrete Repairs Inc. 352 Woodcroft, Hudson, QC J0P 1H0 2015-04-07
Distribution Acra Ltee 4818 Rue Clark, Montreal, QC H2T 2T5 1981-09-09
Les Services De Beton Acra Inc. 352, Woodcroft, Hudson, QC J0P 1H0 1980-02-22
Msf Traducteurs-rÉdacteurs, S.c.c. 5l-6000, Chemin Deacon, Montréal, QC H3S 2T9 1987-05-14
Les Redacteurs Professionnels Cote Et Chaput Inc. 31 Cavanagh, Repentigny, QC J6A 4M2 1979-04-11
Les Redacteurs Publi-consul Inc. 10 Mary Elizabeth Noonan, Suite 401, Chateauguay, QC J6J 5P2 1988-10-03
Acra Training & Consulting Inc. 165 Avenue Road, Suite 401, Toronto, ON M5R 3S4 2007-11-02
Acra Automated Collection Revenue Agency Inc. 69 Jackson Avenue, Etobicoke, ON M8X 2J7 2003-09-03
Apidel Agroalimentaire Inc. 409 Rang Bord De L'eau, Saint-aime, QC J0G 1K0 2004-02-17
Les Communicateurs D'ici Inc. 1434 Rue Cuvillier, MontrÉal, QC H1W 2Z8 1978-03-07

Improve Information

Please provide details on ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS ET RÉDACTEURS DE L'AGROALIMENTAIRE (ACRA) by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Corporations Canada
Jurisdiction Canada
Website www.ic.gc.ca
Entity Count 846524

Trending Searches