Administration portuaire de Rivière au Renard

Address:
3 Rue De La Langevin, RiviÈre Au Renard, QC G4X 5G4

Administration portuaire de Rivière au Renard is a business entity registered at Corporations Canada, with entity identifier is 3261182. The registration start date is May 17, 1996. The current status is Active.

Corporation Overview

Corporation ID 3261182
Business Number 894383199
Corporation Name Administration portuaire de Rivière au Renard
Registered Office Address 3 Rue De La Langevin
RiviÈre Au Renard
QC G4X 5G4
Incorporation Date 1996-05-17
Corporation Status Active / Actif
Number of Directors 5 - 5

Directors

Director Name Director Address
YVON SAVAGE 6 RUE DE L'ENTREPÔT, RIVIÈRE AU RENARD QC G4X 5L4, Canada
JEANNOT JONCAS 3 RUE SAMUEL, RIVIÈRE AU RENARD QC G4X 5H4, Canada
GILLES TAPP 7 RUE DE L'ÉGLISE, RIVIÈRE AU RENARD QC G4X 5E7, Canada
RENAUD SYLVESTRE 25 RUE SAINT-NARCISSE, RIVIÈRE AU RENARD QC G4X 5K3, Canada
GÉRARD-GUY CLOUTIER 200 BOULEVARD RENARD EST, RIVIÈRE AU RENARD QC G4X 5R5, Canada
FERNAND SAVAGE 26 RUE DES VAGUES, PETIT-CAP QC G4X 4M9, Canada
SEBASTIEN DUNN 147 BOULEVARD RENARD OUEST, RIVIERE AU RENARD QC G4X 5B1, Canada
JACQUES DUFRESNE 3 RUE DES VENTS, RIVIÈRE AU RENARD QC G4X 5E1, Canada

Corporation History

Type Effective Date Expiry Date Detail
Act 2013-12-30 current Canada Not-for-profit Corporations Act (NFP Act)
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL)
Act 1996-05-17 2013-12-30 Canada Corporations Act - Part II (CCA - Part II)
Loi sur les corporations canadiennes - partie II (LCC - Partie II)
Act 1996-05-16 1996-05-17 Canada Corporations Act - Part II (CCA - Part II)
Loi sur les corporations canadiennes - partie II (LCC - Partie II)
Address 2013-12-30 current 3 Rue De La Langevin, RiviÈre Au Renard, QC G4X 5G4
Address 2003-03-31 2013-12-30 1 Rue De La Langevin, C.p. 9, Riviere Au Renard, QC G4X 5G4
Address 2001-03-31 2003-03-31 1 Rue De La Langevin, Cp 9, Riviere Au Renard, QC G4X 5G4
Address 1996-05-17 2001-03-31 Riviere Au Renard, QC G0E 2A0
Name 2013-12-30 current Administration portuaire de Rivière au Renard
Name 1996-05-17 2013-12-30 ADMINISTRATION PORTUAIRE DE RIVIERE-AU-RENARD
Status 2013-12-30 current Active / Actif
Status 1996-05-17 2013-12-30 Active / Actif

Activities

Date Activity Details
2013-12-30 Continuance (transition) / Prorogation (transition) Jurisdiction: Canada Corporations Act - Part II (CCA-II) / Loi sur les corporations canadiennes, partie 2 (LCC-Partie 2)
1996-05-17 Incorporation / Constitution en société

Annual Returns Filings

Year Annual Meeting Date Corporation Type
2019 2019-12-20 Non-Soliciting
N'ayant pas recours à la sollicitation
2018 2018-12-19 Non-Soliciting
N'ayant pas recours à la sollicitation
2017 2017-12-21 Non-Soliciting
N'ayant pas recours à la sollicitation

Office Location

Address 3 RUE DE LA LANGEVIN
City RIVIÈRE AU RENARD
Province QC
Postal Code G4X 5G4
Country Canada

Corporations in the same postal code

Corporation Name Office Address Incorporation
Co-gestion Crevette Stellaire Inc. 1 Rue De La Langevin, Riviere Au Renard, QC G4X 5G4 1998-10-01

Corporations in the same postal prefix

Corporation Name Office Address Incorporation
Broderie Au Fil De La Mer Inc. 161, Boul. De Gaspé, Gaspé, QC G4X 1A4 2008-05-20
Azentic Inc. 161 Boul. GaspÉ, GaspÉ, QC G4X 1A4 1999-07-06
Les Placements Guy Proulx Inc. 51, Rue Lejeune, GaspÉ, QC G4X 1C9 2005-07-27
3818942 Canada Inc. 37 Rue ChrÉtien, Bureau Z-1, Gaspe, QC G4X 1E1 2000-10-04
Verifiedata Inc. 37, Rue Chrétien, App26, Gaspé, QC G4X 1E1 2010-12-07
Hotel Yvon Caron Limitee 24 Rue Morin, Gaspe, QC G4X 1E6 1978-12-13
Placements Gary Smith Inc. 49 Rue Pouliot, Gaspe, QC G4X 1H3 1981-12-02
Fonds D'investissement Vision 2020 Inc. 229 Rue Domagaya, Gaspe, QC G4X 1K5 2000-10-25
Optagest (sept-iles) Inc. 229 Domagaya, GaspÉ, QC G4X 1K5 1978-04-18
Gestion Quibeau Drummond Inc. 229 Domagaya, GaspÉ, QC G4X 1K5 1999-03-10
Find all corporations in postal code G4X

Corporation Directors

Name Address
YVON SAVAGE 6 RUE DE L'ENTREPÔT, RIVIÈRE AU RENARD QC G4X 5L4, Canada
JEANNOT JONCAS 3 RUE SAMUEL, RIVIÈRE AU RENARD QC G4X 5H4, Canada
GILLES TAPP 7 RUE DE L'ÉGLISE, RIVIÈRE AU RENARD QC G4X 5E7, Canada
RENAUD SYLVESTRE 25 RUE SAINT-NARCISSE, RIVIÈRE AU RENARD QC G4X 5K3, Canada
GÉRARD-GUY CLOUTIER 200 BOULEVARD RENARD EST, RIVIÈRE AU RENARD QC G4X 5R5, Canada
FERNAND SAVAGE 26 RUE DES VAGUES, PETIT-CAP QC G4X 4M9, Canada
SEBASTIEN DUNN 147 BOULEVARD RENARD OUEST, RIVIERE AU RENARD QC G4X 5B1, Canada
JACQUES DUFRESNE 3 RUE DES VENTS, RIVIÈRE AU RENARD QC G4X 5E1, Canada

Entities with the same directors

Name Director Name Director Address
Chambre de commerce du Grand Paspébiac GILLES TAPP 149 GÉRARD-D-LÉVESQUE EST, PASPÉBIAC QC G0C 2K0, Canada
PÉTROLES CADEKO INC. JACQUES DUFRESNE 4470 BETTY BALDWIN, QUEBEC QC G2A 4C5, Canada
6978681 CANADA INC. JACQUES DUFRESNE 806 DES ROSELINS, LONGUEUIL QC J4G 2P5, Canada
B.F. LORENZETTI & ASSOCIÉS (ONTARIO) INC. Jacques Dufresne 495 Viger Ouest, Suite 3302, Montreal QC H2Z 0B1, Canada
MARSH CLAIMS MANAGEMENT SERVICES (CANADA) LTD. JACQUES DUFRESNE 806 DES ROSELINS, LONGUEUIL QC J4G 2P5, Canada
FIRST LION HOLDINGS INC. JACQUES DUFRESNE 495 Viger West, Suite 3302, Montreal QC H2Z 0B1, Canada
ALBERT WILLCOX & CO. OF CANADA LTD. JACQUES DUFRESNE 806 DES ROSELINS, LONGUEUIL QC J4G 2P5, Canada
DUFRESNE & LETOURNEAU INC. JACQUES DUFRESNE 135 AVENUE GAUVIN, VANIER QC G1M 1Y3, Canada
ENTERPRISE CANADA INSURANCE SERVICES LIMITED JACQUES DUFRESNE 806 DES ROSELINS, LONGUEUIL QC J4G 2P5, Canada
FONDATION DU THEATRE DU MARAIS DE VAL-MORIN Jacques Dufresne 2591 rue Lafleur, Val-David QC J0T 2N0, Canada

Competitor

Search similar business entities

City RIVIÈRE AU RENARD
Post Code G4X 5G4

Similar businesses

Corporation Name Office Address Incorporation
Administration Portuaire De Rivière Madeleine 37 Rue Bellevue, Riviere-madeleine, QC G0E 2B0 1991-03-20
Aquafun De Rivière-au-renard 103 Boulevard Renard Est, Rivière-au-renard, QC G4X 5K7 2019-11-18
Administration Portuaire De Rivière-au-tonnerre C P 157, Rivière-au-tonnerre, QC G0G 2L0 2001-12-17
Administration Portuaire De Grande-rivière 223 Grande-allee Ouest, Quebec, QC G0C 1W0 1991-01-02
Chambre De Commerce Riviere Au Renard C.p. 95, Riviere Au Renard, QC G4X 1S0 1970-10-06
Pecia International Inc. 153 Boul.renard Est, Riviere-au-renard,gaspe, QC G0E 2A0 1997-06-20
Les Developpements Brantco Inc. 48 Boul. Renard Est, Cp 24, Riviere-au-renard, Gaspe, QC G0E 2A0 1980-01-31
Cablo-renard Inc. 11 De L'eglise, Gaspe, Riviere-au-renard, QC G0E 2A0 1981-11-04
Administration Portuaire De L'anse A Valleau 36 Rue Des Touristes, Gaspe, QC G4X 4A4 1991-03-20
Administration Portuaire De Petit-shippagan 2 Rue Du Quai, Lamèque, NB E8T 4R7 1996-01-19

Improve Information

Please provide details on Administration portuaire de Rivière au Renard by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Corporations Canada
Jurisdiction Canada
Website www.ic.gc.ca
Entity Count 846524

Trending Searches