Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant

Address:
101-205 Rue Lacasse, Mont-tremblant, QC J8E 3G6

Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant is a business entity registered at Corporations Canada, with entity identifier is 3909409. The registration start date is February 5, 2002. The current status is Active.

Corporation Overview

Corporation ID 3909409
Business Number 861614717
Corporation Name Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant
Registered Office Address 101-205 Rue Lacasse
Mont-tremblant
QC J8E 3G6
Incorporation Date 2002-02-05
Corporation Status Active / Actif
Number of Directors 1 - 16

Directors

Director Name Director Address
JULIEN HOULE 155 CHEMIN DES MESANGES, MONT-TREMBLANT QC J8E 2C9, Canada
MATHIEU LAPOINTE 1000 CHEMIN DES VOYAGEURS, MONT-TREMBLANT QC J8E 1T1, Canada
DOMINIC RHEAULT 1387 RUE TRUDEL, MONT-TREMBLANT QC J8E 2L4, Canada
MICHEL DUPRAS 783 RUE DE SAINT-JOVITE, MONT-TREMBLANT QC J8E 3J8, Canada
FRANCE PARÉ 810 CHEMIN DES STERNES, NOMININGUE QC J0W 1R0, Canada
JULIE RACINE 1006 ROUTE 117, SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ QC J0T 1P0, Canada
DOMINIQUE PRIMI 499 RUE CHARBONNEAU, MONT-TREMBLANT QC J8E 3H4, Canada
STEPHANIE BERGERON BUREAU 2235 CHEMIN DU VILLAGE, MONT-TREMBLANT QC J8E 1E9, Canada
NATHALIE BOISVERT 4280 MONTÉE RYAN, MONT-TREMBLANT QC J8E 1S4, Canada
MARTIN LETARTRE 100 PLACE DE LA MAIRIE, SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ QC J0T 1J2, Canada
DANNY STEWART 1006 RUE DE SAINT-JOVITE, MONT-TREMBLANT QC J8E 3J8, Canada
FRANCE TREMBLAY -, STATION B CP 2719, MONT-TREMBLANT QC J8E 1B1, Canada
GILLES MONFETTE 300 CHEMIN DES PLEIADES, MONT-TREMBLANT QC J8E 0A7, Canada
JESSICA LÉGER MASSIE 1011 RUE DE SAINTE-JOVITE, MONT-TREMBLANT QC J8E 3J9, Canada
DANY MALTAIS 517 RUE CHARBONNEAU, BUR. 100, MONT-TREMBLANT QC J8E 3H4, Canada

Corporation History

Type Effective Date Expiry Date Detail
Act 2002-02-05 current Boards of Trade Act - Part II (BOTA - Part II)
Loi sur les chambres de commerce - partie II (LCH - Partie II)
Address 2017-03-31 current 101-205 Rue Lacasse, Mont-tremblant, QC J8E 3G6
Address 2002-02-05 2017-03-31 990 Rue Lauzon, Mont-tremblant, QC J8E 3J5
Name 2014-02-06 current Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant
Name 2009-07-30 2014-02-06 Chambre de commerce de Mont-Tremblant
Name 2002-02-05 2009-07-30 Chambre de commerce Ville de Mont-Tremblant
Status 2002-02-05 current Active / Actif

Activities

Date Activity Details
2020-06-25 Ordinary By-Laws Filing / Dépôt de règlement ordinaire
2014-02-06 Amendment / Modification Name Changed.
2013-10-15 Ordinary By-Laws Filing / Dépôt de règlement ordinaire
2010-09-30 Ordinary By-Laws Filing / Dépôt de règlement ordinaire
2009-07-30 Amendment / Modification Name Changed.
2002-04-09 Ordinary By-Laws Filing / Dépôt de règlement ordinaire
2002-02-05 Incorporation / Constitution en société

Annual Returns Filings

Year Annual Meeting Date Corporation Type
2019 2019-03-26
2018 2018-03-27
2017 2017-03-31

Office Location

Address 101-205 RUE LACASSE
City MONT-TREMBLANT
Province QC
Postal Code J8E 3G6
Country Canada

Corporations in the same postal code

Corporation Name Office Address Incorporation
North Motion Inc. 105-426, Rue Lacasse, Mont-tremblant, QC J8E 3G6 2015-04-27

Corporations in the same postal prefix

Corporation Name Office Address Incorporation
Denturologistes Sarrapuchiello Inc. 275, Allée Boréalis, Mont-tremblant, QC J8E 0A4 2014-12-19
Les Placements Raymond Martel Ltee 144 Alée Boréalis, Mont-tremblant, QC J8E 0A4 1981-10-23
10512940 Canada Inc. 6-380 Allée Des Cimes, Mont-tremblant, QC J8E 0B3 2017-11-27
6244661 Canada Inc. 380 AllÉe Des Cimes, Apt 2, Mont-tremblant, QC J8E 0B3 2004-06-07
Gestions Sirilo Inc. 450, Allée-des-cimes, Appartement 2, Mont-tremblant, QC J8E 0B3 1981-02-10
8727830 Canada Inc. 201 Ch. Sous-les-arbres, Mont-tremblant, QC J8E 0B9 2014-06-03
The Hero Maker Group Inc. 201 Chemin Sous-les-arbres, Mont-tremblant, QC J8E 0B9 2010-07-27
4023498 Canada Inc. 201, Chemin Sous-les-arbres, Mont-tremblant, QC J8E 0B9 2002-07-23
4445805 Canada Inc. 355, Allée Du Méandre, Mont-tremblant, QC J8E 0C5 2007-11-21
Maison Myrtle Canada Inc. 905 Chemin Cochrane, Mont-tremblant, QC J8E 0C7 2010-02-12
Find all corporations in postal code J8E

Corporation Directors

Name Address
JULIEN HOULE 155 CHEMIN DES MESANGES, MONT-TREMBLANT QC J8E 2C9, Canada
MATHIEU LAPOINTE 1000 CHEMIN DES VOYAGEURS, MONT-TREMBLANT QC J8E 1T1, Canada
DOMINIC RHEAULT 1387 RUE TRUDEL, MONT-TREMBLANT QC J8E 2L4, Canada
MICHEL DUPRAS 783 RUE DE SAINT-JOVITE, MONT-TREMBLANT QC J8E 3J8, Canada
FRANCE PARÉ 810 CHEMIN DES STERNES, NOMININGUE QC J0W 1R0, Canada
JULIE RACINE 1006 ROUTE 117, SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ QC J0T 1P0, Canada
DOMINIQUE PRIMI 499 RUE CHARBONNEAU, MONT-TREMBLANT QC J8E 3H4, Canada
STEPHANIE BERGERON BUREAU 2235 CHEMIN DU VILLAGE, MONT-TREMBLANT QC J8E 1E9, Canada
NATHALIE BOISVERT 4280 MONTÉE RYAN, MONT-TREMBLANT QC J8E 1S4, Canada
MARTIN LETARTRE 100 PLACE DE LA MAIRIE, SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ QC J0T 1J2, Canada
DANNY STEWART 1006 RUE DE SAINT-JOVITE, MONT-TREMBLANT QC J8E 3J8, Canada
FRANCE TREMBLAY -, STATION B CP 2719, MONT-TREMBLANT QC J8E 1B1, Canada
GILLES MONFETTE 300 CHEMIN DES PLEIADES, MONT-TREMBLANT QC J8E 0A7, Canada
JESSICA LÉGER MASSIE 1011 RUE DE SAINTE-JOVITE, MONT-TREMBLANT QC J8E 3J9, Canada
DANY MALTAIS 517 RUE CHARBONNEAU, BUR. 100, MONT-TREMBLANT QC J8E 3H4, Canada

Entities with the same directors

Name Director Name Director Address
LES ALIMENTS MISSKO FOOD INC. Danny Stewart 65, chemin du Domaine-Millette, Mont-Tremblant QC J8E 1V9, Canada
INSTITUT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA DÉMOCRATIE DANS LE MONDE (IDDM) FRANCE PARÉ 730, RUE MCEACHRAN, OUTREMONT QC H2V 3C7, Canada
LES DISTRIBUTIONS TREMBLAY DE DELISLE INC. france tremblay 2341 ave du pont nord, alma QC G8E 1P7, Canada
BILEM AEROVISION INC. FRANCE TREMBLAY 8352 RUE DU LAUS, ST-LEONARD QC H1R 2P4, Canada
LES INGENIEURS MONFETTE, MILLETTE ET ASSOCIES INC. GILLES MONFETTE 284 RUE EDOUARD, LAVAL QC H7P 2M7, Canada
Priosecur inc. Jessica Léger Massie 1123, chemin de la Marquise Nord, Lac-Simon QC J0V 1E0, Canada
C"hat"-peau La Griffe Inc. JULIE RACINE 1615 DE L'EGLISE SUITE 2, VILLE LEMOYNE QC J4P 2C7, Canada
Strategic Value International Fund Ltd. JULIE RACINE 80 HUDSON, APP.7, TOWN OF MONT-ROYAL QC H3R 1S6, Canada
Strategic Value Canadian Equity Fund Ltd. JULIE RACINE 80 HUDSON, APP.7, TOWN OF MONT-ROYAL QC H3R 1S6, Canada
FLORIDAIR INC. Julien Houle 155, chemin des Mésanges, Mont-Tremblant QC J8E 2C9, Canada

Competitor

Search similar business entities

City MONT-TREMBLANT
Post Code J8E 3G6

Similar businesses

Corporation Name Office Address Incorporation
Chambre De Commerce De Mont-tremblant Mont-tremblant, Box 248, Mont-tremblant, QC J0T 1Z0 1983-06-30
The Chamber of Commerce Town of Mont Royal 4480 Cote De Liesse, Suite 110, Mont Royal, QC H4N 2R1 1990-11-02
Station Mont Tremblant Inc. 1000 Chemin Des Voyageurs, Mont-tremblant, QC J8E 1T1 1991-07-09
Grand Falls District Chamber of Commerce 131 Pleasant St, Ste 200, Grand Falls, NB E3Z 1C8 1951-11-20
Discover Mont-tremblant Inc. 512 Chemin Des Boises, Mont-tremblant, QC J8E 1L5 2004-04-13
Biere Mont-tremblant Inc. 168 Meilleur St, Mont-tremblant, QC J0T 1Z0 1994-10-28
The British Canadian Chamber of Trade and Commerce 130,king Street West, Suite 2300, Toronto, ON M5X 1C8 1951-05-17
Chambre De Commerce Et D'industrie De Grand-mere Inc. 602 6e Avenue, C.p. 322, Grand'mere, QC G9T 5L1 1982-08-11
Chambre De Commerce Baie-des-chaleurs 114-b Ave. Grand-prÉ, Bonaventure, QC G0C 1E0 1980-05-09
Chambre De Commerce De Grand Remous Rr 1, Montcerf Comte Gatineau, QC J8P 6G1 1970-02-23

Improve Information

Please provide details on Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Corporations Canada
Jurisdiction Canada
Website www.ic.gc.ca
Entity Count 846524

Trending Searches