PRODUITS A.I.F. INC.

Address:
536 Rue Cartier, Joliette, QC J7R 6B6

PRODUITS A.I.F. INC. is a business entity registered at Corporations Canada, with entity identifier is 4268857. The registration start date is November 16, 2004. The current status is Dissolved.

Corporation Overview

Corporation ID 4268857
Business Number 862544632
Corporation Name PRODUITS A.I.F. INC.
A.I.F. PRODUCTS INC.
Registered Office Address 536 Rue Cartier
Joliette
QC J7R 6B6
Incorporation Date 2004-11-16
Dissolution Date 2008-04-17
Corporation Status Dissolved / Dissoute
Number of Directors 1 - 10

Directors

Director Name Director Address
FRANCOIS GIASSON 100 RUE GUY, DEUX-MONTAGNES QC J7R 6B6, Canada
ALAIN LAVOIE 155 RUE SAGUINET, REPENTIGNY QC J5Y 1T4, Canada

Corporation History

Type Effective Date Expiry Date Detail
Act 2004-11-16 current Canada Business Corporations Act (CBCA)
Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA)
Address 2008-07-17 current 536 Rue Cartier, Joliette, QC J7R 6B6
Address 2004-11-16 2008-07-17 10 Rue Gilles Vigneault, St-charles Borromee, QC J6E 3C1
Name 2008-07-14 current PRODUITS A.I.F. INC.
Name 2008-07-14 current A.I.F. PRODUCTS INC.
Name 2004-11-16 2008-07-14 PRODUITS A.I.F. INC.
Name 2004-11-16 2008-07-14 A.I.F. PRODUCTS INC.
Status 2010-06-08 current Dissolved / Dissoute
Status 2008-07-14 2010-06-08 Active / Actif
Status 2008-04-17 2008-07-14 Dissolved / Dissoute
Status 2007-11-09 2008-04-17 Active - Dissolution Pending (Non-compliance) / Actif - Dissolution en cours (Non-conformité)
Status 2004-11-16 2007-11-09 Active / Actif

Activities

Date Activity Details
2010-06-08 Dissolution Section: 210(1)
2008-07-14 Revival / Reconstitution
2008-04-17 Dissolution Section: 212
2004-11-16 Incorporation / Constitution en société

Annual Returns Filings

Year Annual Meeting Date Corporation Type
2009 2009-11-18 Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders
Société n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins
2008 2008-12-12 Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders
Société n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins
2007 2007-09-10 Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders
Société n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins

Office Location

Address 536 RUE CARTIER
City JOLIETTE
Province QC
Postal Code J7R 6B6
Country Canada

Corporations in the same location

Corporation Name Office Address Incorporation
4354591 Canada Inc. 536 Rue Cartier, Joliette, QC J6E 4T5 2006-03-22

Corporations in the same postal prefix

Corporation Name Office Address Incorporation
Emd Technologies Inc. 400 Du Parc, Saint-eustache, QC J7R 0A1 2000-11-10
Les Entreprises Joseph Vella Inc. 390, Rue Du Parc, Saint-eustache, QC J7R 0A1
3037835 Canada Inc. 390, Rue Du Parc, Saint-eustache, QC J7R 0A1 1994-05-31
Les Placements Sylvain Laberge Inc. 390, Rue Du Parc, St-eustache, QC J7R 0A1 1987-05-13
Projet X SystÈmes De Cablage StructurÉs Inc. 1-395, Rue Du Parc, Saint-eustache, QC J7R 0A3 2003-01-21
Mineral Origin Inc. 395, Du Parc, Saint-eustache, QC J7R 0A3 2002-10-31
3756998 Canada Inc. 395 Rue Du Parc, Suite 4, Saint-eustache, QC J7R 0A3 2000-05-04
2923459 Canada Inc. 375, Rue Du Parc, Suite 107, Saint-eustache, QC J7R 0A3 1993-05-21
Le Studio De Lettrage St-eustache (1983) Ltee 405 Rue Du Parc, Local #10, Saint-eustache, QC J7R 0A3 1983-09-09
10770302 Canada Inc. 160 Rue Williams, Saint-eustache, QC J7R 0A4 2018-05-07
Find all corporations in postal code J7R

Corporation Directors

Name Address
FRANCOIS GIASSON 100 RUE GUY, DEUX-MONTAGNES QC J7R 6B6, Canada
ALAIN LAVOIE 155 RUE SAGUINET, REPENTIGNY QC J5Y 1T4, Canada

Entities with the same directors

Name Director Name Director Address
ÉVO Technologique 360 inc. ALAIN LAVOIE 475 Avenue du Citadelle, Rimouski QC G5M 1X4, Canada
4354591 CANADA INC. ALAIN LAVOIE 155 RUE SANGUINET, REPENTIGNY QC J5Y 1T4, Canada
3955141 CANADA INC. ALAIN LAVOIE 1044 RUE DE DIJON, STE-FOY, QUÉBEC QC G1W 4M4, Canada
107215 CANADA LTEE ALAIN LAVOIE 240 6IEME AVE CP 205, STE MARGUERITE QC , Canada
COGIRAL LTEE ALAIN LAVOIE 2295 CHEMIN GEORGEVILLE, CANTON DE MAGOG QC J1X 3W4, Canada
3677788 CANADA INC. ALAIN LAVOIE 110 CHEMIN DU ROY, ST-COLOMBAN QC J0N 1N0, Canada
VERSALOG INC. ALAIN LAVOIE 111, rue Sigouin, Trécesson QC J0Y 2S0, Canada
7294069 CANADA INC. ALAIN LAVOIE 110 CHEMIN DU ROI, SAINT-COLOMBAN QC J5K 1C7, Canada
CONSORTIUM CANADIEN POUR L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE EN AFRIQUE CORP. Alain Lavoie 3737 Boulevard Crémazie Est, Suite 300, Montréal QC H1Z 2K4, Canada
Groupe Tactik inc. ALAIN LAVOIE 17 BOUL. L'ASSOMPTION, REPENTIGNY QC J6A 1A3, Canada

Competitor

Search similar business entities

City JOLIETTE
Post Code J7R 6B6

Similar businesses

Corporation Name Office Address Incorporation
Les Produits Rhema's Products Ltd. 157, Carwood Circle, Ottawa, ON K1K 4V6 2017-02-01
Les Produits Éco & Éco Inc. 112 Sherbrooke, Beaconsfield, QC H9W 1N4 2012-04-10
Les Produits R.c.j. Ltee P.o.box 32, Amos, QC 1970-06-16
Les Produits Drc Inc. 9283, Rue Thimens, Pierrefonds, QC H8Y 0A1
Les Produits Arc-fil Ltee 940 Mccaffrey, St Laurent, QC H4T 2C7 1979-08-27
Produits Isb Inc. 2300 Victoria Ave, Lachine, QC H8S 1Z3 1995-11-17
Les Produits Drc Inc. 9283 Thimens, Pierrefonds, QC H8Y 0A1 2011-02-16
Les Produits Fdb Inc. 1410, Rue Principale, #104, Ste-julie, QC J3E 1R6 2002-04-24
Les Produits Merisa Products Inc. 180 Hector, Rosemere, QC J7A 2Z6 1991-10-11
Les Produits Caloair Products Inc. 106 57e Avenue, St-eustache, QC J7P 3L4 1978-07-04

Improve Information

Please provide details on PRODUITS A.I.F. INC. by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Corporations Canada
Jurisdiction Canada
Website www.ic.gc.ca
Entity Count 846524

Trending Searches