Gouvernement Confédération des Peuples Autochtones du Canada

Address:
117 (b), Fer à Cheval, Gatineau, QC J8M 1L8

Gouvernement Confédération des Peuples Autochtones du Canada is a business entity registered at Corporations Canada, with entity identifier is 4320956. The registration start date is September 20, 2005. The current status is Active.

Corporation Overview

Corporation ID 4320956
Business Number 822983870
Corporation Name Gouvernement Confédération des Peuples Autochtones du Canada
Government Confederation of Aboriginal People of Canada
Registered Office Address 117 (b), Fer à Cheval
Gatineau
QC J8M 1L8
Incorporation Date 2005-09-20
Dissolution Date 2015-02-24
Corporation Status Active / Actif
Number of Directors 3 - 3

Directors

Director Name Director Address
Dianne Racicot 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Suzanne Brousseau 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Barry Bélanger 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Gilles Gagné 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Jacy Carle 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Jean-Guy Charest 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Pierre Lajeunesse 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Robert Mason 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Guy-Carl Thérieault 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Fernand Bell 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Rock Paradis 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Lise Canard Blanc 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Guillaume Grand Chef National Carle 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
France Bélanger 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Réjean Bigras 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Eric Fournier 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Alvin Manitopyes 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Chantal Paquin 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Jean-Claude Sénécal 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Maranger Roger 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Chayton Carle 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Jocelyne Niquay 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Sonia Carrier 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Steve Larouche 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Michel Séguin 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Jacques Delandes 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Yvonne Simon 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
John Chiasson 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Yves Girard 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Fernand Niquay 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Marie-Pierre Bertrand 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Michel Papineau 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Luc Michaud 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Lynn Hollister 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada

Corporation History

Type Effective Date Expiry Date Detail
Act 2014-07-29 current Canada Not-for-profit Corporations Act (NFP Act)
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL)
Act 2005-09-20 2014-07-29 Canada Corporations Act - Part II (CCA - Part II)
Loi sur les corporations canadiennes - partie II (LCC - Partie II)
Address 2017-02-07 current 117 (b), Fer à Cheval, Gatineau, QC J8M 1L8
Address 2017-01-17 2017-02-07 19 Angus Georges Boulevard, Akwesasne, QC H0M 1A0
Address 2015-01-20 2017-01-17 19 Merlin, Gatineau, QC J9A 3M5
Address 2014-07-29 2015-01-20 117b Fer A Cheval, Gatineau, QC J8M 1L8
Address 2009-03-31 2014-07-29 117 Fer A Cheval, Gatineau, QC J8M 1L8
Address 2005-09-20 2009-03-31 12 Rue Des Chutes-rheaume, Gatineau, QC J8M 1A6
Name 2017-01-17 current Gouvernement Confédération des Peuples Autochtones du Canada
Name 2017-01-17 current Government Confederation of Aboriginal People of Canada
Name 2015-01-18 2017-01-17 THE CONFEDERATION OF ABORIGINAL PEOPLE OF CANADA
Name 2015-01-18 2017-01-17 LA CONFEDERATION DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA
Name 2014-11-03 2015-01-18 THE GOVERNMENT OF THE CONFEDERATION OF ABORIGINAL PEOPLE OF CANADA
Name 2014-11-03 2015-01-18 LE GOUVERNEMENT DE LA CONFEDERATION DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA
Name 2014-07-29 2014-11-03 CONFEDERATION OF ABORIGINAL PEOPLE OF CANADA
Name 2014-07-29 2014-11-03 CONFÉDÉRATION DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA
Name 2005-09-20 2014-07-29 Confederation of Aboriginal People of Canada
Name 2005-09-20 2014-07-29 Confédération des peuples Autochtones du Canada
Status 2015-03-04 current Active / Actif
Status 2015-02-24 2015-03-04 Dissolved / Dissoute
Status 2014-07-29 2015-02-24 Active / Actif
Status 2005-09-20 2014-07-29 Active / Actif

Activities

Date Activity Details
2017-01-17 Amendment / Modification Name Changed.
RO Changed.
Directors Limits Changed.
Section: 201
2015-03-04 Revival / Reconstitution
2015-02-24 Dissolution Section: 220(1)
2015-01-18 Amendment / Modification Name Changed.
Section: 201
2014-11-03 Amendment / Modification Name Changed.
Directors Limits Changed.
Section: 201
2014-07-29 Continuance (transition) / Prorogation (transition) Jurisdiction: Canada Corporations Act - Part II (CCA-II) / Loi sur les corporations canadiennes, partie 2 (LCC-Partie 2)
2005-09-20 Incorporation / Constitution en société

Annual Returns Filings

Year Annual Meeting Date Corporation Type
2017 2017-12-20 Non-Soliciting
N'ayant pas recours à la sollicitation
2016 2016-12-06 Non-Soliciting
N'ayant pas recours à la sollicitation
2015 2015-12-06 Non-Soliciting
N'ayant pas recours à la sollicitation

Office Location

Address 117 (B), Fer à Cheval
City Gatineau
Province QC
Postal Code J8M 1L8
Country Canada

Corporations in the same postal code

Corporation Name Office Address Incorporation
Horseshoe Health Inc. 317 Ch. Du Fer-a-cheval, Gatineau, QC J8M 1L8 2020-08-24
11760203 Canada Inc. Chemin Du Fer-À-cheval, Gatineau, QC J8M 1L8 2019-11-26
11606956 Canada Inc. 621, Chemin Du Fer-à-cheval, Gatineau, QC J8M 1L8 2019-09-05
9760911 Canada Inc. 319 Chemin Du Fer-à-cheval, Gatineau, QC J8M 1L8 2016-05-19
8985324 Canada Inc. 301, Chemin Du Fer-à-cheval, Gatineau, QC J8M 1L8 2014-08-12
8719837 Canada Inc. 319 Ch. Du Fer-à-cheval, Gatineau, QC J8M 1L8 2013-12-09
8154643 Canada Inc. 295, Chemin Du Fer-à-cheval, Gatineau, QC J8M 1L8 2013-11-11
8647267 Canada Inc. 655, Chemin Du Fer-à-cheval, Gatineau, QC J8M 1L8 2013-09-27
Gestion Jfg Inc. 621 Chemin Fer-à-cheval, Gatineau, QC J8M 1L8 2013-01-03
8251754 Canada Inc. 585 Chemin Du Fer à Cheval, Gatineau, QC J8M 1L8 2012-07-16
Find all corporations in postal code J8M 1L8

Corporation Directors

Name Address
Dianne Racicot 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Suzanne Brousseau 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Barry Bélanger 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Gilles Gagné 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Jacy Carle 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Jean-Guy Charest 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Pierre Lajeunesse 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Robert Mason 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Guy-Carl Thérieault 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Fernand Bell 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Rock Paradis 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Lise Canard Blanc 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Guillaume Grand Chef National Carle 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
France Bélanger 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Réjean Bigras 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Eric Fournier 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Alvin Manitopyes 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Chantal Paquin 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Jean-Claude Sénécal 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Maranger Roger 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Chayton Carle 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Jocelyne Niquay 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Sonia Carrier 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Steve Larouche 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Michel Séguin 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Jacques Delandes 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Yvonne Simon 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
John Chiasson 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Yves Girard 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Fernand Niquay 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Marie-Pierre Bertrand 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Michel Papineau 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Luc Michaud 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada
Lynn Hollister 117 (B) Fer à Cheval, Gatineau QC J8M 1L8, Canada

Entities with the same directors

Name Director Name Director Address
Cree Capture Resources Inc. ALVIN MANITOPYES 11 ERIN LINK SE, CALGARY AB T2B 3H9, Canada
3905926 CANADA INC. CHANTAL PAQUIN 2809 DES BUSES, MASCOUCHE QC J7K 3Y1, Canada
4190751 CANADA INC. ERIC FOURNIER 6027 MERIEL ST., ST. LEONARD QC H1P 2V9, Canada
8967717 Canada Ltd. Eric Fournier 53 Brazeau, L'Ange-Gardien QC J8L 0G3, Canada
4190718 CANADA INC. ERIC FOURNIER 6027 MERIEL STREET, ST. LEONARD QC H1P 2V9, Canada
7325959 CANADA LTD. ERIC FOURNIER 53 BRAZEAU, L'ANGE-GARDIEN QC J8L 2W7, Canada
Board of Trade of Metropolitan Montreal ERIC FOURNIER 6250 RUE HUTCHISON, MONTREAL QC H2V 4C5, Canada
Innovator Electronic Assembly Inc. ERIC FOURNIER 1159 MONTPELLIER STREET, ST-LEONARD QC H4L 4R3, Canada
EmbryoGENE2 inc. Eric Fournier 1731, rue Turmel, L'Ancienne-Lorette QC G2E 5C3, Canada
3666522 CANADA INC. ERIC FOURNIER 1359 COURSOL, REPENTIGNY QC J5Y 4C8, Canada

Competitor

Search similar business entities

City Gatineau
Post Code J8M 1L8

Similar businesses

Corporation Name Office Address Incorporation
Kwe! À La Rencontre Des Peuples Autochtones 250 Place Michel Laveau #201, Wendake, QC G0A 4V0 2018-11-30
Les Habitations Abordables Des Peuples Autochtones (hapa) 33 Rue Lafayette, Gatineau, QC J8P 2T8 2006-12-19
Développement Des Peuples Aborigènes Du Canada, Inc. 415 Brittany Drive, Ottawa, ON K1K 0R9 2007-05-08
ConfÉdÉration Panafricaine Des Investissements 401-417, Rue Saint-pierre, Montréal, QC H2Y 2M4 2019-04-03
Le Mouvement Confederation 5527 Young St., Suite 201, Toronto, ON M2N 5S3 1977-09-30
Confédération Canadienne Des Cadres 2430 Chemin Sainte-foy, Quebec, QC G1V 1T2 2009-04-28
La Confederation, Compagnie D'assurance-vie 321 Bloor Street East, Toronto, ON M4W 1H1 1871-04-14
Fondation Confederation L'apprentissage A La Voile 1579 Dresden Row, Halifax, NS B3J 2K4 1982-10-26
Motorcyclists Confederation of Canada 13 Eureka Street, Lambton Shores, ON N0N 1J0 2005-01-18
International Commission for Rights of Ethnic Minorities and Aboriginal People (canada) 7098 Rue Chambord, Montreal, QC H2E 1W4 1989-11-29

Improve Information

Please provide details on Gouvernement Confédération des Peuples Autochtones du Canada by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Corporations Canada
Jurisdiction Canada
Website www.ic.gc.ca
Entity Count 846524

Trending Searches