Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest

Address:
600 Rue 2 Est, Bureau 203, La Sarre, QC J9Z 2J5

Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest is a business entity registered at Corporations Canada, with entity identifier is 5258. The registration start date is August 13, 1953. The current status is Active.

Corporation Overview

Corporation ID 5258
Business Number 879642940
Corporation Name Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest
Registered Office Address 600 Rue 2 Est
Bureau 203
La Sarre
QC J9Z 2J5
Incorporation Date 1953-08-13
Corporation Status Active / Actif
Number of Directors 12 - 12

Directors

Director Name Director Address
PATRICK PERREAULT 571 RUE DU COTEAU, LA SARRE QC J9Z 2E3, Canada
MICHEL THERRIEN 939 CHEMIN DES LINAIGRETTES, PALMAROLLE QC J0Z 3C0, Canada
LYNE CARREAU 409 ROUTE 393, MACAMIC QC J0Z 2S0, Canada
MIKE CAUDRON 49 AVE LIMOGES, APP 5, LA SARRE QC J9Z 3C2, Canada
LUC MICHAUD 685 ROUTE 111 OUEST, MACAMIC QC J0Z 2S0, Canada
CAROLE PARADIS 5 RUE AUDET, LA SARRE QC J9Z 2T9, Canada
RONALD DURHAM 620 RUE DU PARC, LA SARRE QC J9Z 2S1, Canada
SYLVAIN VACHON 664 4E-ET-5E RANG OUEST, PALMAROLLE QC J0Z 3C0, Canada
GENEVIEVE SAINDON-L'ÉCUYER 593 RUE DU COTEAU, LA SARRE QC J9Z 2E3, Canada
ERIC PELLETIER 421 RANG 8 ET 9 OUEST, POULARIES QC J0Z 3E0, Canada
ANDREE-ANNE BEDARD 709 AVE. BARIL OUEST, POULARIES QC J0Z 3E0, Canada

Corporation History

Type Effective Date Expiry Date Detail
Act 1953-08-13 current Boards of Trade Act - Part II (BOTA - Part II)
Loi sur les chambres de commerce - partie II (LCH - Partie II)
Act 1953-08-12 1953-08-13 Boards of Trade Act - Part II (BOTA - Part II)
Loi sur les chambres de commerce - partie II (LCH - Partie II)
Address 2019-05-17 current 600 Rue 2 Est, Bureau 203, La Sarre, QC J9Z 2J5
Address 2014-03-31 2019-05-17 364-a Rue Principale, La Sarre, QC J9Z 1Z5
Address 2008-03-31 2014-03-31 99 5e Ave Est, Suite 203, La Sarre, QC J9Z 3A8
Address 1953-08-13 2008-03-31 258 2e Rue Est, Suite 202, La Sarre, QC J9Z 2H2
Name 2008-02-28 current Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest
Name 1992-05-07 2008-02-28 Chambre de Commerce de l'Abitibi-Ouest
Name 1953-08-13 1992-05-07 Chambre de Commerce de La Sarre
Status 1953-08-13 current Active / Actif

Activities

Date Activity Details
2008-02-28 Amendment / Modification Name Changed.
2003-06-06 Ordinary By-Laws Filing / Dépôt de règlement ordinaire
1953-08-13 Incorporation / Constitution en société

Annual Returns Filings

Year Annual Meeting Date Corporation Type
2019 2018-06-11
2017 2017-09-19
2018 2017-06-20

Office Location

Address 600 Rue 2 Est
City La Sarre
Province QC
Postal Code J9Z 2J5
Country Canada

Corporations in the same postal prefix

Corporation Name Office Address Incorporation
Karine Morin Dentiste Inc. 665 2e Rue Est, La Sarre, QC J9Z 0A7 2009-11-12
Association of Canadian Cartoonists 24 Pelletier, Gatineau, QC J9Z 1C5 1988-03-25
Air Terre Service Courrier Inc. 14, 3e Avenue Ouest, La Sarre, QC J9Z 1G7 1989-04-24
Conteneurs Multiblast Inc. 176 3e Avenue Est, La Sarre, QC J9Z 1J2 2019-09-24
7917759 Canada Inc. 84, 5ème Avenue Est, Lasarre, QC J9Z 1K9 2011-07-14
Bioxfor Inc. 50a 5e Avenue Est, La Sarre, QC J9Z 1K9 2010-10-06
6669468 Canada Inc. 84, 5e Avenue Est, La Sarre, QC J9Z 1K9 2006-12-07
Varietes Norli Inc. 84 5ieme Avenue Est, La Sarre, QC J9Z 1K9 1980-09-17
6567291 Canada Inc. 78, 8ème Avenue Ouest, La Sarre, QC J9Z 1N3 2006-05-10
4272501 Canada Inc. 78 8e Avenue Ouest, La Sarre, QC J9Z 1N3 2004-12-15
Find all corporations in postal code J9Z

Corporation Directors

Name Address
PATRICK PERREAULT 571 RUE DU COTEAU, LA SARRE QC J9Z 2E3, Canada
MICHEL THERRIEN 939 CHEMIN DES LINAIGRETTES, PALMAROLLE QC J0Z 3C0, Canada
LYNE CARREAU 409 ROUTE 393, MACAMIC QC J0Z 2S0, Canada
MIKE CAUDRON 49 AVE LIMOGES, APP 5, LA SARRE QC J9Z 3C2, Canada
LUC MICHAUD 685 ROUTE 111 OUEST, MACAMIC QC J0Z 2S0, Canada
CAROLE PARADIS 5 RUE AUDET, LA SARRE QC J9Z 2T9, Canada
RONALD DURHAM 620 RUE DU PARC, LA SARRE QC J9Z 2S1, Canada
SYLVAIN VACHON 664 4E-ET-5E RANG OUEST, PALMAROLLE QC J0Z 3C0, Canada
GENEVIEVE SAINDON-L'ÉCUYER 593 RUE DU COTEAU, LA SARRE QC J9Z 2E3, Canada
ERIC PELLETIER 421 RANG 8 ET 9 OUEST, POULARIES QC J0Z 3E0, Canada
ANDREE-ANNE BEDARD 709 AVE. BARIL OUEST, POULARIES QC J0Z 3E0, Canada

Entities with the same directors

Name Director Name Director Address
8491798 CANADA CORPORATION Eric Pelletier 21 rue de Boischatel, Cantley QC J8V 4G2, Canada
Sphère Performance Inc. Eric PELLETIER 3128, rue des Peupliers, Sainte-Marthe-sur-le-Lac QC J0N 1P0, Canada
La Chambre de Commerce de Saint-François de Madawaska ERIC PELLETIER C.P. 378, MADAWASKA NB E7A 1G4, Canada
Canadian Lithium Association Eric Pelletier 824 Coach Side Cres SW, Calgary AB T3H 1A3, Canada
11912216 Canada Inc. Eric Pelletier 25 Montée des Becs Croisés, Val-des-Monts QC J8N 4C6, Canada
KALLOS WARRIORS LTD. Eric Pelletier 337-4267 St-Catherine West, Westmount QC H3Z 1P7, Canada
2K75 INC. LUC MICHAUD 4650 Lacombe, MONTREAL QC H3W 1R3, Canada
Coddict Inc. Luc Michaud 4650 Avenue Lacombe, Montreal QC H3W 1R3, Canada
LUC MICHAUD ECONOMISTE CONSEIL/LOGICIELS-EXPERT LTEE LUC MICHAUD 4650 Lacombe, MONTREAL QC H3W 1R3, Canada
WEBCREATOR INC. Luc Michaud 4650, av. Lacombe, Montréal QC H1L 3K3, Canada

Competitor

Search similar business entities

City La Sarre
Post Code J9Z 2J5

Similar businesses

Corporation Name Office Address Incorporation
Chambre De Commerce Et D'industrie Du Centre-abitibi 644 1re Avenue Ouest, Amos, QC J9T 1V3 1920-07-08
Chambre De Commerce Et D'industrie Canada-liban 1400 Sauve Ouest, #204, Montreal, QC H4N 1C5 1989-08-23
Fondation De La Chambre De Commerce Et D’industrie Canada Liban 1805 Rue Sauvé Ouest #308, Montréal, QC H4N 3B8 2009-02-04
Chambre De Commerce Et D'industrie Lac-saint-jean-est 640 Cote-ouest, Alma, QC G8B 7S8 1945-11-09
Chambre De Commerce Et D'industrie Du Sud-ouest De Montréal 410 Avenue Lafleur, Bur. 32, Lasalle, QC H8R 3H6 1952-05-31
Chambre De Commerce Et D'industrie De La Mrc De Maskinongé 871 Boul. St-laurent Ouest, Bureau 200, Louiseville, QC J5V 1J3 1939-04-14
Chambre De Commerce Et De L'industrie Rimouski-neigette 23 Rue De L'ÉvÊchÉ Ouest, Bur. 100, Rimouski, QC G5L 4H4 1908-06-05
Chamber of Commerce Industry and Tourism Canada - West and Center Africa (ccit-cwca) 443 Avenue Dumont, Ste 619, Dorval`, QC H9S 5W2 1995-02-22
Chambre Chilienne D'industrie Et Commerce à Montréal 24 Mont-royal Ouest, Suite 403, Montreal, QC H3T 2S2 2007-09-11
Chambre De Commerce Et D'industrie Russe Du QuÉbec 3221, Autoroute Laval Ouest, Bureau 203, Laval, QC H7P 5P2 2015-08-04

Improve Information

Please provide details on Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Corporations Canada
Jurisdiction Canada
Website www.ic.gc.ca
Entity Count 846524

Trending Searches