PRODUITS RÉCRÉATIFS ACCÈS INC.

Address:
1080 Grande AllÉe Ouest, Quebec, QC G1K 7M3

PRODUITS RÉCRÉATIFS ACCÈS INC. is a business entity registered at Corporations Canada, with entity identifier is 6332544. The registration start date is January 7, 2005. The current status is Active.

Corporation Overview

Corporation ID 6332544
Business Number 857914030
Corporation Name PRODUITS RÉCRÉATIFS ACCÈS INC.
Registered Office Address 1080 Grande AllÉe Ouest
Quebec
QC G1K 7M3
Incorporation Date 2005-01-07
Corporation Status Active / Actif
Number of Directors 1 - 9

Directors

Director Name Director Address
DENIS RICARD 51 CHEMIN DU RIVAGE, PONT-ROUGE QC G3H 1H9, Canada

Corporation History

Type Effective Date Expiry Date Detail
Act 2005-01-07 current Canada Business Corporations Act (CBCA)
Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA)
Address 2011-08-02 current 1080 Grande AllÉe Ouest, Quebec, QC G1K 7M3
Address 2005-01-07 2011-08-02 8840, Boul. Taschereau, Brossard, QC J4X 1C2
Name 2005-01-07 current PRODUITS RÉCRÉATIFS ACCÈS INC.
Status 2005-01-07 current Active / Actif

Activities

Date Activity Details
2005-01-07 Incorporation / Constitution en société

Annual Returns Filings

Year Annual Meeting Date Corporation Type
2020 2019-05-15 Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders
Société n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins
2019 2018-05-25 Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders
Société n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins
2018 2017-05-26 Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders
Société n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins

Office Location

Address 1080 GRANDE ALLÉE OUEST
City QUEBEC
Province QC
Postal Code G1K 7M3
Country Canada

Corporations in the same postal code

Corporation Name Office Address Incorporation
2025 West Broadway Holdings Ltd. 1080 Grande Allée West, Box 1907, Station Terminus, Quebec, QC G1K 7M3 2010-11-26
Industrielle Alliance Valeurs MobiliÈres Inc. - 1080 Chemin St-louis, Sillery, QC G1K 7M3 1970-09-22
Ia Clarington Investments Inc. 1080, Grande AllÉe Ouest, QuÉbec, QC G1K 7M3
Investia Services Financiers Inc. 1080 Grande Allee Ouest, Quebec, QC G1K 7M3
Ia Clarington Investments Inc. 1080 Grande AllÉe Ouest, QuÉbec, QC G1K 7M3
Industrial Alliance Mutual Funds Inc. 1080 Grande Allée Ouest, Québec, QC G1K 7M3
Protection V.a.g. Inc. 1080 Grande Allée Ouest, Québec, QC G1K 7M3 2011-02-02
L'edifice 2000 Ave. Mcgill College Inc. 1080 Grande-allÉe Ouest, C.p. 1907 Succursale Terminus, QuÉbec, QC G1K 7M3 1984-04-24

Corporations in the same postal prefix

Corporation Name Office Address Incorporation
Productions Se Inc. 15-200, Rue Lalemant, Québec, QC G1K 0C2 2015-10-08
Association Al-jama'a 280 Rue Du Prince-Édouard, Apt 506, Québec, QC G1K 0E9 2015-10-22
Enjeux Du Droit 701-380, Rue De La Couronne, Québec, QC G1K 0G5 2020-06-26
11570897 Canada Inc. 203-26, Rue De La Pointe-aux-lièvres, Québec, QC G1K 0G6 2019-08-15
Goretti Music Ltd. 346 Rue Ste-agnÈs, Apt #4, Quebec, QC G1K 1E9 2005-04-28
Epicerie G.a. Ratte Inc. 202 Rue Taschereau, QuÉbec, QC G1K 1G7 1980-04-18
11566725 Canada Inc. 3-293 Rue Cardinal-taschereau, QuÉbec, QC G1K 1G8 2019-08-13
3608336 Canada Inc. 76, St-vallier, Quebec, QC G1K 1J6 1999-06-15
Bioté Cosmétiques Inc. 135 Rue Saint-vallier W., Québec, QC G1K 1J9 2009-09-03
4312651 Canada Inc. 216 Rue Saint-vallier Ouest, Suite 2, Québec, QC G1K 1K2 2005-09-28
Find all corporations in postal code G1K

Corporation Directors

Name Address
DENIS RICARD 51 CHEMIN DU RIVAGE, PONT-ROUGE QC G3H 1H9, Canada

Competitor

Search similar business entities

City QUEBEC
Post Code G1K 7M3

Similar businesses

Corporation Name Office Address Incorporation
C.c.g.d. Recreational Products Inc. 80 Gillespie, Ottawa, ON K1V 9X8 1983-02-23
Jab Produits RÉcrÉatifs Inc. 911, Rue Principale, Bureau 21, Batiscan, QC G0X 1A0 2008-04-23
Les Produits Recreatifs Gilbert Ltee 1100 Est, Cremazie, Suite 803, Montreal, QC 1977-03-07
Les Produits Recreatifs Poly Inc. 1060 Marie Victorin, Boucherville, QC J4B 5E4 1981-09-28
Les Produits Recreatifs W 3 Ltee. 2093 Matterhorn, Munic. Val David, QC 1983-12-09
H2o! Recreational Products Inc. 7200 Martin Grove Road, Woodbridge, ON L4L 9J3 2007-05-03
Bombardier Produits RÉcreatifs Inc. 726 St-joseph Street, Valcourt, QC J0E 2L0
Fabrication De Produits Recreatifs Ampro Inc. 871 De Lotbiniere, Vaudreuil Dorion, QC J7V 8P2 1982-07-14
Produits Recreatifs Ingleby Inc. 259 Champlain Street, Suite 102, Hull, QC J8X 3R9 1989-06-12
Les Produits Recreatifs Arctic Ltee 1615 Inkster Boulevard, Winnipeg, MB R2X 2V1 1969-05-22

Improve Information

Please provide details on PRODUITS RÉCRÉATIFS ACCÈS INC. by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Corporations Canada
Jurisdiction Canada
Website www.ic.gc.ca
Entity Count 846524

Trending Searches