ARCADE: AGENCE DE RECHERCHE, CONSULTATION ET AIDE AU DEVELOPPEMENT INC.

Address:
600 Mcgregor, Apt. 309, Sherbrooke, QC J1L 1V7

ARCADE: AGENCE DE RECHERCHE, CONSULTATION ET AIDE AU DEVELOPPEMENT INC. is a business entity registered at Corporations Canada, with entity identifier is 702081. The registration start date is May 1, 1978. The current status is Dissolved.

Corporation Overview

Corporation ID 702081
Business Number 880312798
Corporation Name ARCADE: AGENCE DE RECHERCHE, CONSULTATION ET AIDE AU DEVELOPPEMENT INC.
Registered Office Address 600 Mcgregor
Apt. 309
Sherbrooke
QC J1L 1V7
Incorporation Date 1978-05-01
Dissolution Date 1995-07-26
Corporation Status Dissolved / Dissoute
Number of Directors 2 - 7

Directors

Director Name Director Address
ARMANDE GUINDON CENTRE BOIS-JOLI, ST-DENIS BROMPT QC J0B 2P0, Canada
JEAN-CHARLES GUINDON CENTRE BOIS-JOLI, ST-DENIS BROMPT QC J0B 2P0, Canada

Corporation History

Type Effective Date Expiry Date Detail
Act 1978-05-01 current Canada Business Corporations Act (CBCA)
Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA)
Act 1978-04-30 1978-05-01 Canada Business Corporations Act (CBCA)
Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA)
Address 1978-05-01 current 600 Mcgregor, Apt. 309, Sherbrooke, QC J1L 1V7
Name 1978-05-01 current ARCADE: AGENCE DE RECHERCHE, CONSULTATION ET AIDE AU DEVELOPPEMENT INC.
Status 1995-07-26 current Dissolved / Dissoute
Status 1984-08-07 1995-07-26 Active - Dissolution Pending (Non-compliance) / Actif - Dissolution en cours (Non-conformité)
Status 1978-05-01 1984-08-07 Active / Actif

Activities

Date Activity Details
1995-07-26 Dissolution
1978-05-01 Incorporation / Constitution en société

Annual Returns Filings

Year Annual Meeting Date Corporation Type
1984 1983-05-30 Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders
Société n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins

Office Location

Address 600 MCGREGOR
City SHERBROOKE
Province QC
Postal Code J1L 1V7
Country Canada

Corporations in the same postal code

Corporation Name Office Address Incorporation
122031 Canada Ltee 690 Mcgregor, Suite 308, Sherbrooke, QC J1L 1V7 1983-03-09
120679 Canada Inc. 610 Rue Mcgregor App. 38, Sherbrooke, QC J1L 1V7 1982-12-30
Robert De La Conception Decorateur Inc. 610 Rue Mcgregor, Suite 47, Sherbrooke, QC J1L 1V7 1981-09-03
Centre D'equipement J.n. De Sherbrooke Inc. 520 Mcgregor, Sherbrooke, QC J1L 1V7

Corporations in the same postal prefix

Corporation Name Office Address Incorporation
La Coulée, Eau D'érable Pétillante Ltée 2977 Rue Du Sauvignon, Sherbrooke, QC J1L 0A1 2017-08-18
Oxynova Hyperbare Inc. 4242, Boulevard De Portland, Sherbrooke, QC J1L 0A3 2014-07-30
Exo8 Inc. 4242, Rue De Portland, Sherbrooke, QC J1L 0A3
Afflu-o Inc. 4242, Boulevard De Portland, Sherbrooke, QC J1L 0A3 2017-09-08
Skysmith Inc. 130 Sauvé, Sherbrooke, QC J1L 0A7 2014-04-25
6316034 Canada Inc. 130, Rue Sauvé, Sherbrooke, QC J1L 0A7 2004-11-25
Investissement Hatley Inc. 130 Rue Sauvé, Sherbrooke, QC J1L 0A7 2001-04-19
10242969 Canada Inc. 130, Rue Sauvé, Sherbrooke, QC J1L 0A7 2017-05-19
184496 Canada Inc. 130 Rue Sauvé, Sherbrooke, QC J1L 0A7 1984-05-14
Marc-antoine Despatis M.d. Inc. 2685, Honoré-de-balzac, Sherbrooke, QC J1L 0B2 2009-07-28
Find all corporations in postal code J1L

Corporation Directors

Name Address
ARMANDE GUINDON CENTRE BOIS-JOLI, ST-DENIS BROMPT QC J0B 2P0, Canada
JEAN-CHARLES GUINDON CENTRE BOIS-JOLI, ST-DENIS BROMPT QC J0B 2P0, Canada

Entities with the same directors

Name Director Name Director Address
SONAMIC INC. JEAN-CHARLES GUINDON CENTRE BOIS-JOLI, ST-DENIS BROMPT QC J0B 2P0, Canada

Competitor

Search similar business entities

City SHERBROOKE
Post Code J1L1V7

Similar businesses

Corporation Name Office Address Incorporation
Arcade Tourist Development Inc. 1010 Rue Sherbrooke-ouest, Suite 1100, Montreal, QC H3A 2R7 1985-08-07
La Fondation De L'association Des Centres D'aide Aux Entreprises En Recherche, Developpement Et Formation 2015 Berlier, Bur 230, Chomedey, QC H7L 3H9 1993-03-09
Agence Canadienne De Communications, D'analyse Et De Recherche En Développement (accard) Inc. 3450 Rue Drummond, Bur. 1023b, Montreal, QC H3G 1Y3 1993-10-12
Services De Consultation En Recherche Et Développement Permani (amérique Du Nord) Inc. 8068 Croissant Cyrenne, Lasalle, QC H8P 3T1 2006-08-08
Psm Research and Consultation Inc. Box 963 Succ B, Montreal, QC 1980-06-11
Arcade Packaging Inc. 7342 Mountain Sights Ave, Montreal, QC H4P 2A6 1982-08-10
Aide Recherche Mondiale (wra) 6065 Boul. Thimens, St-laurent, QC H4S 1V8 2006-06-22
Service D'aide Et Soutien Au Développement De La Personne M.r. Inc. 335, Rue Laurier, App. 1a, Laval, QC H7N 2N3 2010-06-18
ComitÉ International Pour L'aide D'urgence Et Le DÉveloppement 139 Rue De Duniere, Gatineau, QC J8V 0G3 2015-07-03
SociÉtÉ D'aide Au DÉveloppement De La CollectivitÉ De Papineau Inc. 565 Avenue De Buckingham, Gatineau, QC J8L 2H2 1984-12-19

Improve Information

Please provide details on ARCADE: AGENCE DE RECHERCHE, CONSULTATION ET AIDE AU DEVELOPPEMENT INC. by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Corporations Canada
Jurisdiction Canada
Website www.ic.gc.ca
Entity Count 846524

Trending Searches