Chambre de commerce régionale de Sainte-Foy

Address:
2700 Boul. Laurier, Bur. 3200, Édifice Champlain, QuÉbec, QC G1V 4K5

Chambre de commerce régionale de Sainte-Foy is a business entity registered at Corporations Canada, with entity identifier is 8231. The registration start date is November 4, 1954. The current status is Active.

Corporation Overview

Corporation ID 8231
Corporation Name Chambre de commerce régionale de Sainte-Foy
Registered Office Address 2700 Boul. Laurier
Bur. 3200, Édifice Champlain
QuÉbec
QC G1V 4K5
Incorporation Date 1954-11-04
Corporation Status Active / Actif
Number of Directors 11 - 11

Directors

Director Name Director Address
MARIE-JOSÉE LAFLAMME 690 BOUL. RENÉ-LÉVESQUE EST, QUEBEC QC G1R 5A8, Canada
MICHEL DROLET 410 BOUL. CHAREST EST, QUEBEC QC G1K 7J6, Canada
YVAN LACHANCE 2700 BOUL LAURIER, BUREAU 3200, STE-FOY QC G1V 4K5, Canada
ROBERT MONETTE 2875 BOUL. LAURIER, 10E ÉTAGE, STE-FOY QC G1V 2M2, Canada
ANDRÉ DI VITA 1080 CHEMIN SAINT-LOUIS, QUEBEC QC G1K 7M3, Canada
HUGO LÉPINE 2700 BOUL. LAURIER, BUR. 3200, QUÉBEC QC G1V 4K5, Canada
ALAIN VAILLANCOURT 5600 BOUL DES GALERIES, BUREAU 110, QUEBEC QC G2K 2H6, Canada
ROBERT PICHÉ 1041 BOUL. PIERRE-BERTRAND, BUR. 160, QUEBEC QC G1M 2E8, Canada
STEPHAN VIAU 1635 AVE. DE NIVERVILLE, QUEBEC QC G1J 2K1, Canada
MAUDE LEMIEUX 5600 BOUL. DES GALERIES, BUREAU 140, QUEBEC QC G2H 2H6, Canada
OLIVIER DUFOUR 101 QUAI SAINT-ANDRÉ, BUR. 1, QUEBEC QC G1K 3Y3, Canada
LUC PARADIS 3075 CHEMIN DES QUATRE-BOURGEOIS, BUR. 400, QUEBEC QC G1W 4X5, Canada
MANON ROBICHAUD PAVILLON ALPHONSE-DESJARDINS LOCAL 2447, UNIVERSITÉ LAVAL, QUEBEC QC G1K 7P4, Canada
JEAN-MARC LESSARD 455 DES ENTREPRENEURS, QUEBEC QC G1M 2V2, Canada

Corporation History

Type Effective Date Expiry Date Detail
Act 1954-11-04 current Boards of Trade Act - Part II (BOTA - Part II)
Loi sur les chambres de commerce - partie II (LCH - Partie II)
Act 1954-11-03 1954-11-04 Boards of Trade Act - Part II (BOTA - Part II)
Loi sur les chambres de commerce - partie II (LCH - Partie II)
Address 2006-03-31 current 2700 Boul. Laurier, Bur. 3200, Édifice Champlain, QuÉbec, QC G1V 4K5
Address 2002-03-31 2006-03-31 2700 Boul. Laurier Edifice Champlain, Bureau 3200, Ste-foy, QC G1V 4K5
Address 1954-11-04 2002-03-31 2700 Boul. Laurier, Ste-foy, QC G1V 2L8
Name 1990-09-18 current Chambre de commerce régionale de Sainte-Foy
Name 1954-11-04 1990-09-18 Chambre de Commerce de Ste-Foy
Status 1954-11-04 current Active / Actif

Activities

Date Activity Details
2006-06-19 Ordinary By-Laws Filing / Dépôt de règlement ordinaire
1954-11-04 Incorporation / Constitution en société

Annual Returns Filings

Year Annual Meeting Date Corporation Type
2006 2006-06-13
2003 2002-06-12
2001 2000-06-05

Office Location

Address 2700 BOUL. LAURIER
City QUÉBEC
Province QC
Postal Code G1V 4K5
Country Canada

Corporations in the same location

Corporation Name Office Address Incorporation
149520 Canada Inc. 2700 Boul. Laurier, C.p. 31089, Ste-foy, QC G1V 4W6 1986-03-19
Groupe Boucher Sports Inc. 2700 Boul. Laurier, Bureau 3000, Edifice Champlain, Québec, QC G1V 4K5

Corporations in the same postal code

Corporation Name Office Address Incorporation
6961886 Canada Inc. 2700 Boul. Laurier - Édifice Champlain, Bureau 3200, Québec, QC G1V 4K5 2008-04-21
G.p.g. Devimco Inc. 2700, Boulevard Laurier, Bureau 3200, Québec, QC G1V 4K5 1999-01-27
Hydrologic "h21" Inc. 2700 Boulevard Laurier, Bureau 6320, Sainte Foy, QC G1V 4K5 1993-03-16

Corporations in the same postal prefix

Corporation Name Office Address Incorporation
Global Food Regulatory Science Society 2425, Rue De L'agriculture, , Pavillon Comtois Cmt 1309, Québec, QC G1V 0A6 2020-09-28
Bio6 Inc. 2305 Rue De L'université, Québec, QC G1V 0A6 2020-03-26
Nice Roy Canada Inc. 2325 Rue De L'université, Chambre 3705, Quebec, QC G1V 0A6 2019-08-07
Aedepul 2300 Rue De La Terrasse, Québec, QC G1V 0A6 2016-09-21
R-biopharm Canada Inc. 2440, Boulevard Hochelaga, Suite 2729d, Québec, QC G1V 0A6 2016-08-31
Amundsen Science 1045 Av. De La Médecine, Local 3432, Pavi. Alexandre-vachon, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 2015-04-30
Icef12 Université Laval (attn. Cristina Ratti), 2425 Rue De L'agriculture (room 2407), Québec, QC G1V 0A6 2013-09-11
Vacs International Inc. 2320 Rue Des Bibliotheques, Quebec, QC G1V 0A6 2009-03-23
Association Pour Les Ingrédients Santé En Alimentation (a.i.s.a.) 2440 Boulevard Hochelaga, Quebec, QC G1V 0A6 2005-11-29
Mngsf Inc. 2325 Rue De La Terasse, Bureau 1661 C.p. 3811, Quebec, QC G1V 0A6 2005-05-24
Find all corporations in postal code G1V

Corporation Directors

Name Address
MARIE-JOSÉE LAFLAMME 690 BOUL. RENÉ-LÉVESQUE EST, QUEBEC QC G1R 5A8, Canada
MICHEL DROLET 410 BOUL. CHAREST EST, QUEBEC QC G1K 7J6, Canada
YVAN LACHANCE 2700 BOUL LAURIER, BUREAU 3200, STE-FOY QC G1V 4K5, Canada
ROBERT MONETTE 2875 BOUL. LAURIER, 10E ÉTAGE, STE-FOY QC G1V 2M2, Canada
ANDRÉ DI VITA 1080 CHEMIN SAINT-LOUIS, QUEBEC QC G1K 7M3, Canada
HUGO LÉPINE 2700 BOUL. LAURIER, BUR. 3200, QUÉBEC QC G1V 4K5, Canada
ALAIN VAILLANCOURT 5600 BOUL DES GALERIES, BUREAU 110, QUEBEC QC G2K 2H6, Canada
ROBERT PICHÉ 1041 BOUL. PIERRE-BERTRAND, BUR. 160, QUEBEC QC G1M 2E8, Canada
STEPHAN VIAU 1635 AVE. DE NIVERVILLE, QUEBEC QC G1J 2K1, Canada
MAUDE LEMIEUX 5600 BOUL. DES GALERIES, BUREAU 140, QUEBEC QC G2H 2H6, Canada
OLIVIER DUFOUR 101 QUAI SAINT-ANDRÉ, BUR. 1, QUEBEC QC G1K 3Y3, Canada
LUC PARADIS 3075 CHEMIN DES QUATRE-BOURGEOIS, BUR. 400, QUEBEC QC G1W 4X5, Canada
MANON ROBICHAUD PAVILLON ALPHONSE-DESJARDINS LOCAL 2447, UNIVERSITÉ LAVAL, QUEBEC QC G1K 7P4, Canada
JEAN-MARC LESSARD 455 DES ENTREPRENEURS, QUEBEC QC G1M 2V2, Canada

Entities with the same directors

Name Director Name Director Address
128928 CANADA INC. ALAIN VAILLANCOURT 2654 PLACE DES GRIVES, LAVAL QC H7L 3W5, Canada
FONDATION ABBE VIANNEY SAVARIA ALAIN VAILLANCOURT 1071 RUE DE CATHEDRALE, MONTREAL QC H3B 2V4, Canada
3373738 Canada Inc. ALAIN VAILLANCOURT 195, rue Radmore, Gatineau QC J8R 3T5, Canada
174849 CANADA INC. ALAIN VAILLANCOURT 337 RUE DE MORENCY, GATINEAU QC J8V 3R1, Canada
6828655 CANADA INC. ALAIN VAILLANCOURT 195 RUE RADMORE, GATINEAU QC J8R 3T5, Canada
CALFEUTRAGE GENERAL ROD INC. Alain Vaillancourt 201 rue Guénette, Ste-Anne-des-Plaines QC J0N 1H0, Canada
OEUVRE DE LA SOUPE ALAIN VAILLANCOURT 1030 APT. 102 DES ACACIAS, LA TUQUE QC G9X 3X3, Canada
8547262 Canada Inc. Alain VAILLANCOURT 195, rue Radmore, Gatineau QC J8R 3T5, Canada
LA SOCIÉTÉ AÉROPORTUAIRE DE QUÉBEC ALAIN VAILLANCOURT 2900, RUE DU GRAND-VOYER, QUEBEC QC G1W 4Y7, Canada
GLYPHES VIRTUELS INC. ALAIN VAILLANCOURT 815 BOUL. SAINT-RENE EST, GATINEAU QC J8P 1T2, Canada

Competitor

Search similar business entities

City QUÉBEC
Post Code G1V 4K5

Similar businesses

Corporation Name Office Address Incorporation
Chambre De Commerce Régionale De St-raymond 100 Av. St-jacques, Bureau 1, St-raymond, QC G3L 3Y1 1967-11-30
Chambre De Commerce Régionale De Windsor C.p. 115, Windsor, QC J1S 2L7 1966-10-25
Chambre De Commerce Et D'industrie Régionale De Saint-léonard D'aston 370 Principale, Bureau 1, St-leonard D'aston, QC J0C 1M0 1978-09-20
Chambre De Commerce De La Haute-gaspésie 96 Boulevard Sainte-anne Ouest, Sainte-anne-des-monts, QC G4V 1R3 1992-10-09
La Chambre De Commerce Du Comté Saguenay Sainte-marguerite, QC 1937-05-20
Chambre De Commerce De La Mrc De Bellechasse 159-b Boul. Begin, Sainte-claire, QC G0R 2V0 1959-05-26
Chambre De Commerce Et D'industrie Al-maghreb/canada 890 De La Terrasse, Sainte-adele, QC J8B 1T4 2001-04-05
Chambre De Commerce De Sainte-adèle 1370 Boul. De Sainte-adÈle, Sainte-adÈle, QC J8B 0K2 1944-04-11
Chambre De Commerce Et D'industrie Nouvelle-beauce 174 Notre-dame Sud, Sainte-marie, QC G6E 4A1 1930-04-15
Chambre De Commerce Et D'industrie Canada-cuba 1341 B Principale, Sainte Julie, QC J3E 0C4 2015-08-03

Improve Information

Please provide details on Chambre de commerce régionale de Sainte-Foy by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Corporations Canada
Jurisdiction Canada
Website www.ic.gc.ca
Entity Count 846524

Trending Searches