Canada · Corporation

Jurisdiction: Canada
Register: Corporations Canada

This dataset contains listing of 0.85m corporations incorporated with Corporations Canada, Innovation, Science and Economic Development Canada. Each corporation is registered with the following information: corporation number, corporate name, office address (street address, city, postal code), current status, governing legislation, directors, annual filling dates, etc.

1000 DE LA GAUCHETIÈRE STREET WEST · Search Result

Corporation Name Office Address Incorporation
7850069 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 2011-04-29
7924372 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2011-08-26
8016224 Canada Inc. 1000 De La GauchÉtiere Street West, 24th Floor, MontrÉal, QC H3B 4W5 2011-11-04
Stellate Systems Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5
8063923 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 200, Montréal, QC H3B 4W5 2011-12-29
Silverback Two Canada Merger Corporation 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 900, Montreal, QC H3B 5H4 2012-01-25
Tenrox Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 900, Montreal, QC H3B 5H4
8109826 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2012-12-19
8109834 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 2012-12-19
Labec Realty Advisors Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2012-07-19
8313644 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 900, Montréal, QC H3B 5H4
Pro Reit Management Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, #2100, Montréal, QC H3B 4W5 2012-11-14
Pro Reit Gp Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2012-11-14
Gdrjl Holdings Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2012-12-12
Ware Hill Investments Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2013-01-15
Pro Reit Acquisition (1) Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2013-01-25
Sanderling Ventures Vii (canada) Management Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2013-02-06
8504695 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2013-11-22
8504709 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2013-11-22
8504717 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2013-11-22
8504873 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2015-07-14
Etching Productions, Ltd. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2400, Montreal, QC H3B 4W5 2013-06-03
8541973 Canada Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2013-06-07
Ashburton Holdings Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2500, MontrÉal, QC H3B 0A2
8109834 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5
7623704 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5
Trustifi Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 3700, Montreal, QC H3B 4W5 2004-11-30
Npi Wind Power Gp II Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 900, Montreal, QC H3B 5H4 2004-12-13
Mont-louis Wind Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 900, Montreal, QC H3B 5H4 2004-12-13
Northland Power Wind Gp I Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 900, Montreal, QC H3B 5H4 2004-12-13
Npi Wind Power Gp I Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 900, Montreal, QC H3B 5H4 2004-12-13
Northland Power Wind Gp II Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 900, Montreal, QC H3B 5H4 2004-12-13
6331190 Canada Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2100, MontrÉal, QC H3B 4W5 2005-01-05
Pscp Laval/notre Dame, Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2100, MontrÉal, QC H3B 4W5 2005-01-05
6331289 Canada Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2100, MontrÉal, QC H3B 4W5 2005-01-05
6331301 Canada Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2100, MontrÉal, QC H3B 4W5 2005-01-05
6331327 Canada Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2100, MontrÉal, QC H3B 4W5 2005-01-05
6331343 Canada Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2100, MontrÉal, QC H3B 4W5 2005-01-05
6331394 Canada Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2100, MontrÉal, QC H3B 4W5 2005-01-05
6358021 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 3700, Montreal, QC H3B 4Y7 2005-03-03
Vice Media Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 3700, Montreal, QC H3B 4W5
Shahir Guindi Avocat Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2014-01-10
Forti Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, 24 Floor, Montreal, QC H3B 4W5 2014-04-09
8913404 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 900, Montreal, QC H3B 5H4
9014039 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2900, Montréal, QC H3B 4W5 2014-09-09
9019618 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 900, Montreal, QC H3B 5H4 2014-09-15
8859507 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5
8859574 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5
9110577 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 900, Montreal, QC H3B 5H4 2015-01-01
Silver Wifi Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2400, Montreal, QC H3B 4W5 2015-01-06
9206850 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2015-12-23
Vice Media Distribution (canada) Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 3700, Montreal, QC H3B 4W5 2015-07-23
Es Participations Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 2017-09-28
All Gp Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2015-09-29
Ope Gp Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2015-09-29
Ips Gp Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2015-09-29
Lan Gp Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2015-09-29
Lio Gp Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2015-09-29
Raz Gp Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2015-09-29
Raz II Gp Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2015-09-29
Lcf Gp Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2015-09-29
Pge Gp Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2015-09-29
Cry Gp Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2015-10-05
Gal Gp Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2015-10-05
Lak Gp Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2015-10-05
Lan II Gp Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2015-10-05
Maj Gp Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2015-10-05
Pge II Gp Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2015-12-07
Gestion Joy Murad Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 200, Montreal, QC H3B 4W5 2015-12-10
9467947 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2900, Montréal, QC H3B 4W5 2017-03-09
Carjess-jennaid Holdings Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2015-12-24
Trevats Investments Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 900, Montreal, QC H3B 5H4
Anthera Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2016-04-13
Hencor-champlain Plastics Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2016-04-19
Rq Terminals Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montréal, QC H3B 0A2 2016-07-15
Fund Forward Capital Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2016-09-27
Vice Productions (fubar) Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 3700, Montreal, QC H3B 4W5 2016-10-06
Ekhosoft Holdings Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2016-10-13
Noa Home Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 2016-10-31
10002917 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montréal, QC H3B 0A2 2016-11-30
10066257 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 3700, Montréal, QC H3B 4W5 2017-01-18
10036277 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 3700, Montréal, QC H3B 4W5 2017-03-21
10126225 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 900, Montreal, QC H3B 5H4 2017-03-01
Rca Gp Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2017-03-09
Mrm Proteomics Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5
Nbs Marketing Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5
10306851 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 3700, Montréal, QC H3B 4W5 2017-07-04
Remedium Ai Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 3700, Montréal, QC H3B 4W5 2017-07-04
Har Gp Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2017-07-11
Canbro Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2500, MontrÉal, QC H3B 0A2 1982-04-28
125576 Canada Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 1984-02-23
Lombard Odier Services Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2449, Montréal, QC H3B 4W5 1984-04-25
Unified Heart Productions Foundation 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 3700, Montréal, QC H3B 4W5 2017-09-14
Inadmin Riskco Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 1410, Montréal, QC H3B 4W5 2017-11-22
Pneus SupÉrieurs Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5
Services LÉgaux Kevin Bianchini Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 900, Montréal, QC H3B 5H4 2017-12-22
Vice Productions QuÉbec I Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 3700, Montréal, QC H3B 4W5 2018-02-01
Power Factors Canada Ltd. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2018-03-12
Okafor Energy Ltd. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2400, Montréal, QC H3B 4W5 2018-05-16
Okafor Enterprises Ltd. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2400, Montréal, QC H3B 4W5 2018-05-16