Canada · Corporation

Jurisdiction: Canada
Register: Corporations Canada

This dataset contains listing of 0.85m corporations incorporated with Corporations Canada, Innovation, Science and Economic Development Canada. Each corporation is registered with the following information: corporation number, corporate name, office address (street address, city, postal code), current status, governing legislation, directors, annual filling dates, etc.

H3B 4W5 · Search Result

Corporation Name Office Address Incorporation
Immeubles Jerveth Inc. 1000 De La Gauchetiere Ouest, Suite 2900, Montreal, QC H3B 4W5 1990-08-16
Immeubles B.r.o.d. Inc. 1000 De La Gauchetiere Ouest, #4310, Montreal, QC H3B 4W5 1990-08-22
Public Television Association of Quebec 1000 Rue De La Gauchetière Ouest, 3700, Montreal, QC H3B 4W5 1990-09-21
2936259 Canada Inc. 1000, Rue De La GauchetiÈre Ouest, Bureau 3700, Montreal, QC H3B 4W5 1993-07-09
Gl Capital Inc. 1000 Rue De La Gauchetiere Ouest, Bureau 4300, Montreal, QC H3B 4W5 1993-07-16
Comprecor Inc. 1000 De La GauchetiÈre West, Suite 2900, Montreal, QC H3B 4W5 1993-08-27
Auberge West Brome (restaurants) Inc. 1000 De La Gauchetiere West, Suite 3500, Montreal, QC H3B 4W5 1993-11-04
Gestion Flares Inc. 1000 Rue De La Gauchetière Ouest, Suite 3700, Montréal, QC H3B 4W5 1993-11-29
Elco Moteurs Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 1993-12-01
Pictet Outre-mer Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 3100, Montreal, QC H3B 4W5 1993-12-07
National Manufacturing of Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere Street, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5
3015203 Canada Inc. 1000, Rue De La GauchetiÈre Ouest, Bureau 2100, MontrÉal, QC H3B 4W5 1994-03-16
A.c.h. Business Consultants Inc. 1000 De La Gauchetiere, Suite 200, Montreal, QC H3B 4W5 1995-01-20
Canadian Friends of Israel Free Loan Association, Inc. 1000, Rue De La Gauchetiere Ouest, Bureau 3700, Montreal, QC H3B 4W5 1995-01-30
Enfotec Technical Services Inc. 1000 Rue De La GauchetiÈre West, 3500, Montreal, QC H3B 4W5 1995-03-08
Immeuble Laurent & Claire Inc. 1000, Rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 4300, Montréal, QC H3B 4W5 1995-05-01
3189643 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere W, Suite 900, Montreal, QC H3B 4W5 1995-10-04
Delauer Capital Corporation 1000, De La GauchetiÈre Street West, Suite 2400, Montreal, QC H3B 4W5 2000-06-07
3773922 Canada Inc. 1000 Rue De La Gauchetiere Ouest, Bureau 2900, Montreal, QC H3B 4W5 2000-08-30
3780325 Canada Inc. 1000 De La GauchetiÈre West, Suite 2900, MontrÉal, QC H3B 4W5 2000-06-27
Planification D'investissements Financiers "p.i.f." Holding Inc. 1000, Rue De La GauchetiÈre Ouest, Bureau 2400, MontrÉal, QC H3B 4W5 2000-06-28
3461611 Canada Inc. 1000 Rue De La GauchetiÈre Ouest, Bureau 4310, MontrÉal, QC H3B 4W5
Ssgm Investments Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 3700, Montréal, QC H3B 4W5 2000-08-25
Setlakwe Capital Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 3500, Montreal, QC H3B 4W5 2000-09-19
Entreprises Outrade.com Canada LtÉe 1000 De La Gauchetiere W., Suite 2600, Montreal, QC H3B 4W5 2000-11-02
3844081 Canada Inc. 1000 Rue De La GauchetiÈre Ouest, Bureau 4310, MontrÉal, QC H3B 4W5 2001-04-18
3845494 Canada Inc. 1000 Rue De La Gauchetiere Ouest, Bureau 2600, Montreal, QC H3B 4W5 2000-12-14
Rochford Recherche De Cadres Incorporée 1000 De La Gauchetière, Bureau 2400, Montréal, QC H3B 4W5 2000-12-15
Le Bronx Inc. 1000 Rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 2900, Montreal, QC H3B 4W5 2001-01-30
Cpcs Personnel Inc. 1000 De La Gauchetiere West, Suite 2900, Montreal, QC H3B 4W5 2001-02-09
3876403 Canada Inc. 1000 Rue De La Gauchetiere Ouest, Bureau 4310, Montreal, QC H3B 4W5 2001-06-18
3876411 Canada Inc. 1000 Rue De La Gauchetiere Ouest, Bureau 4310, Montreal, QC H3B 4W5 2001-06-20
3914712 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere Ouest, Suite 2600, Montreal, QC H3B 4W5 2001-06-29
Afosys.com Inc. 1000 De La Gauchetiere Ouest, Bureau 2600, Montreal, QC H3B 4W5 2001-07-13
Maple Mdx Holdings Inc. 1000 De La GauchetiÈre West, Suite 2900, Montreal, QC H3B 4W5 2002-04-10
Biodyne Water Reclamation Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 2002-10-28
Webill4u System Inc 1000 Rue De La Gauchetiere, 24e Etage, Montreal, QC H3B 4W5 2002-11-15
St-raymond Veneers Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 2003-02-04
Greg Chamandy Investments Inc. 3700-1000, Rue De La Gauchetière Ouest, Montréal, QC H3B 4W5 2002-12-16
4145861 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 2003-05-29
SantÉ Bb Inc. 1000, Rue De La GauchetiÈre Ouest, Bureau 4300, MontrÉal, QC H3B 4W5 2003-07-21
4152956 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere, Bureau 2400, Montreal, QC H3B 4W5 2003-03-31
4162137 Canada Inc. 1000 Rue De La GauchetiÈre Ouest, Bureau 2100, MontrÉal, QC H3B 4W5 2003-04-24
Silk and Steel Projects 1000 De La GauchetiÈre West, Suite 2900, Montreal, QC H3B 4W5 2003-06-27
Le Groupe Mavemco LtÉe 1000 Rue De La GauchetiÈre Ouest, 24 Étage, MontrÉal, QC H3B 4W5 2003-07-04
Groupe Denise Pitre Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2700, Montreal, QC H3B 4W5 2003-10-21
4196651 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 3700, Montreal, QC H3B 4W5 2003-11-05
The Presidents Cup 2007 Canadian Promotional Fund 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 2005-08-11
Jazz Air Holding Gp Inc. - 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 2005-08-23
4328523 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere Ouest, Bureau 2400, Montreal, QC H3B 4W5 2005-10-31
4329929 Canada Inc. 1000, Rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 2100, Montréal, QC H3B 4W5
Mark Brender Société Professionnelle Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2005-12-23
Services Telste Ltee 1000 Rue De La Gauchetière Ouest, 3700, Montreal, QC H3B 4W5
Pictet Asset Management Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 3100, Montreal, QC H3B 4W5 2007-03-20
Lacerta Research Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 2009-01-08
Cquest Investor Relations Inc. 1000 De La Gauchetiere, Bureau 2400, Montreal, QC H3B 4W5 2007-04-02
4431472 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 2007-07-03
4431481 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 2007-07-03
4431651 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 2007-07-19
Canada Media Ventures Corporation 1000 De La Gauchetière West, Suite 2448, Montreal, QC H3B 4W5 2007-08-29
Vice Guide Productions Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 3700, Montréal, QC H3B 4W5 2007-11-14
Lmmc Endowment Fund 1000 De La Gauchetiere Ouest, Suite 3500, Montreal, QC H3B 4W5 2007-12-19
Pscp Quebec Holdings Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5
4463854 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere, Suite 2400, Montreal, QC H3B 4W5 2008-03-03
Pathy Family Foundation Suite 3500, 1000 De La Gauchetiere Ouest, Montreal, QC H3B 4W5 2008-06-05
4478657 Canada Inc. 1000, Rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 2900, Montréal, QC H3B 4W5 2009-02-06
Fondation Prince Albert II De Monaco (canada) 1000, Rue De La GauchetiÈre Ouest, Bureau 2100, Montreal, QC H3B 4W5 2008-07-16
Berrymac Acquisition Limited 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5
Berry Plastics Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5
Cellulogix International Consulting Inc. 1000 De La GauchetiÈre West, #2400, Montreal, QC H3B 4W5 2008-11-26
Makaha Engineering Services Inc. 1000, De La GauchetiÈre Ouest, 24ième Étage, MontrÉal, QC H3B 4W5 2008-10-07
Qualiti7 International Inc. 1000 Rue De La Gauchetiere Ouest, Bureau 2400, Montreal, QC H3B 4W5
R.h.h. Ltd. 1010 De La Gauchetière West, Suite 200, Montréal, QC H3B 4W5
7109661 Canada Inc. 1000 Rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 2100, Montréal, QC H3B 4W5
Talon Aircraft Inc. 1010 De La Gauchetiere St. W., #2414, Montreal, QC H3B 4W5 2009-05-28
Whole Planet Foundation 1000 Rue De La Gauchetière Ouest, Suite 3700, Montreal, QC H3B 4W5 2009-06-11
Stellate Systems Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5
4528999 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 2009-09-24
4529006 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 2009-09-24
Vimac Capital Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 2002-10-15
@tlantec Partners Inc. 1000 De La GauchetiÈre Ouest, Bureau 2900, MontrÉal, QC H3B 4W5 2003-02-18
Pictet Private Management Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 3100, Montreal, QC H3B 4W5 2003-06-12
Gss La (canada) Inc. 1000, Rue De La GauchetiÈre Ouest, Bureau 2900, MontrÉal, QC H3B 4W5 2003-07-16
Vimac Life Science North Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 2003-07-25
Unidiamond Exploration Corp. 1000 De La Gauchetiere West, Suite 1400, Montreal, QC H3B 4W5 2003-10-23
Capital Abtb Inc. 1000, Rue De La GauchetiÈre Ouest, Bureau 2900, MontrÉal, QC H3B 4W5 2005-09-08
Sensyo Spas Inc. 1000 Rue De La GauchetiÈre Ouest, Suite 2400, Montreal, QC H3B 4W5 2005-10-28
Aubie J. Herscovitch Jurico Inc. 1000 De La GauchetiÈre West, Suite 2900, Montreal, QC H3B 4W5 2006-01-13
Gestion De Placements Hélène Dion Inc. 1000, Rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 1150 à Compter Du 2017-11-25, Montréal, QC H3B 4W5 2007-05-01
6772820 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, 24th Floor, Montreal, QC H3B 4W5 2007-05-16
6796761 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière West, Suite 2900, Montreal, QC H3B 4W5 2007-07-01
6804373 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 2007-07-10
Cvrd Aluminum Holdings Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, 2100, Montreal, QC H3B 4W5 2007-07-10
6811604 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière West, Suite 2900, Montreal, QC H3B 4W5 2007-08-01
Donkey Shot Productions Inc. 1000, Rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 2900, Montréal, QC H3B 4W5 2007-09-10
Boutiques Axesoir By This & That Inc. 1000, De La Gauchetière, Suite 1500, Montréal, QC H3B 4W5 2007-10-07
112366 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere West, Suite 900, Montreal, QC H3B 4W5 1981-11-16
Bombardier Produits RÉcrÉatifs Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 2003-11-03
Cibc Global Asset Management (usa) Ltd. 1000 De La GauchetiÈre St. West, Suite 3200, Montreal, QC H3B 4W5 2004-06-30
Les SystÈmes Électroniques C-mac Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5