Canada · Corporation

Jurisdiction: Canada
Register: Corporations Canada

This dataset contains listing of 0.85m corporations incorporated with Corporations Canada, Innovation, Science and Economic Development Canada. Each corporation is registered with the following information: corporation number, corporate name, office address (street address, city, postal code), current status, governing legislation, directors, annual filling dates, etc.

G1N · Search Result

Corporation Name Office Address Incorporation
Location Lou-cam Plus Inc. 1060, Boulevard Charest Ouest, Quebec, QC G1N 0A3
Le Conseil Pour La Mise En Valeur Des Ressources Secondaires 615 De Montmartre St., Quebec, QC G1N 1B3 1980-05-15
Neofarm Corp. 571 St-vallier Ouest, Québec, QC G1N 1C3 2014-10-07
Promotion Pointcom Inc. 569 St-vallier Ouest, Quebec, QC G1N 1C3 2000-01-21
Bherco Inc. 694, Rue St-vallier Ouest, QuÉbec, QC G1N 1C8 2006-11-29
Hiddealer Inc. 939 Rue St-vallier O., Quebec, QC G1N 1G2 2006-11-01
Station Leopold Levesque Inc. 1225 St-vallier Ouest, Quebec, QC G1N 1H1 1979-11-02
Lao Tv Canada Inc. 1275 Rue Borne, QuÉbec, QC G1N 1M5 2005-07-07
Fondation De La 55ième Compagnie Médicale 1020 Rue Vincent Massey, St-malo, QC G1N 1M8 1998-11-02
Les Aliments Denico Inc. 1240, Des Artisans, Québec, QC G1N 1N3 2010-09-09
6528236 Canada Corp. 529 Rue Dollard, QuÉbec, QC G1N 1P2 2006-02-25
Vidacom Inc. 786 Raoul-jobin, Quebec, QC G1N 1S3 2000-06-12
Groupe Conseil Chg Inc. 825, Rue Raoul-jobin, Quebec, QC G1N 1S6 1979-11-16
Chg Drone Inc. 825, Rue Raoul-jobin, Québec, QC G1N 1S6 2019-05-17
L'amie 300-840 Rue Raoul-jobin, Quebec, QC G1N 1S7 1974-11-25
Acm Québec Inc. 960 Rue Raoul Jobin, Local G, Quebec, QC G1N 1S9 2020-07-09
140823 Canada Inc. 592 Rene-grenier, QuÉbec, QC G1N 1T8 1985-04-11
Liens Import Export Inc. 571, Rue Boisseau, QuÉbec, QC G1N 1X3 2004-07-29
Construction Alexandre Ouellet Inc. 634 Napoléon, Québec, QC G1N 1Y8 2015-04-16
Centre Dentaire Des Laurentides Inc. 661, Rue Jacques-bédard, Bur. 500, Québec, QC G1N 2C5 2010-07-21
10643777 Canada Inc. 777, Boulevard Charest Ouest, Québec, QC G1N 2C6 2018-06-30
12274281 Canada Inc. 777, Boulevard Charest Ouest, Québec, QC G1N 2C6 2020-08-17
Aka Eth Innovation Inc. 891, Boulevard Charest Ouest, Québec, QC G1N 2C9 2017-11-09
Security Kebbek Logon & Sentinel Corp. 1173, Boul. Charest, Local 210-7, Québec, QC G1N 2C9 2014-01-29
NavgÉoint Inc. 1173 Boul. Charest O, 2105, Québec, QC G1N 2C9 2013-12-17
Global Air Services Inc. 891, Boul. Charest Ouest, Québec, QC G1N 2C9 2012-02-03
Chron-optic Inc. 891, Boulevard Charest Ouest, Bureau 20, QuÉbec, QC G1N 2C9 2009-06-16
4474201 Canada Inc. 891 Boulevard Charest Ouest, Bureau 200, Quebec, QC G1N 2C9 2008-05-01
Immeuble Dld Inc. 895, Boulevard Charest Ouest, Bureau 203, Québec, QC G1N 2C9 2006-01-11
Welch, Bussières, Avocats Inc. 891, Boulevard Charest Ouest, Bur 200, Québec, QC G1N 2C9 2005-06-17
6327761 Canada Inc. 1175 Charest, Quebec, QC G1N 2C9 2004-12-21
Technoconseil Tc Inc. 1177 Boul. Charest, Bureau 100, QuÉbec, QC G1N 2C9 2003-04-07
6058949 Canada Inc. 1265, Boulevard Charest Ouest, Bureau 1200, QuÉbec, QC G1N 2C9 2003-01-28
4042484 Canada Inc. 1177 Boul. Charest Ouest, Bureau 100, QuÉbec, QC G1N 2C9 2002-04-09
Gfg-camint Inc. 1173 Boul. Charest Ouest, Bureau 300-7, Quebec, QC G1N 2C9 1995-08-16
Dorion, Noël & Hallissey Inc. 1265, Boulevard Charest Ouest, Bureau 1200, Quebec, QC G1N 2C9
Memostars Inc. 891 Boulevard Charest Ouest, Bureau 200, Quebec, QC G1N 2C9 2009-02-03
4515072 Canada Inc. 891 Boulevard Charest Ouest, Quebec, QC G1N 2C9 2009-04-16
Lsa Technologies Inc. 891 Boulevard Charest Ouest, Bureau 200, Quebec, QC G1N 2C9 2012-03-27
Aeroloc Inc. 891 Boulevard Charest Ouest, Quebec, QC G1N 2C9 2013-01-03
Ueat Technologies Inc. 1130, Boulevard Charest Ouest, Québec, QC G1N 2E2 2017-05-29
Ardon Retread Systems Canada Inc. 117-1240 Boul. Charest Ouest, Quebec, QC G1N 2E3 2000-01-26
Pieces D'auto Economiques Inc. 1240 Boulevard Charest Ouest, Québec, QC G1N 2E3 1980-08-01
Distribution Pae Inc. 1240 Boulevard Charest Ouest, Québec, QC G1N 2E3 2017-05-02
Orapi-dry Shine Products Inc. 102-1963, Rue Frank-carrel, Québec, QC G1N 2E6 2010-03-17
SociÉtÉ De Gestion Comi 2000 LtÉe 1963 Jean--talon Sud, Ste-foy, QC G1N 2E6 2000-03-01
3333281 Canada Inc. 1963 Jean Talon Sud, Ste-foy, QC G1N 2E6 1996-12-24
Kanevas Inc. 1375 Frank-carrel Local 30, Québec, QC G1N 2E7 2016-07-16
Gestion 3 R-v Inc. 1375 Boulevard Charest Ouest, Local 5, Québec, QC G1N 2E7 2005-12-06
Entreprise Cofix Inc. 1375 Rue Frank-carrel, #8, QuÉbec, QC G1N 2E7 2005-09-12
Les Pneus Industriels RemoulÉs M.b. Inc. 1375 Boul. Charest Ouest, Bureau 5, Quebec, QC G1N 2E7 2002-11-25
Serigraphie Serid'art Inc. 1375 Frank-carrel, Porte 19, Quebec, QC G1N 2E7
Les Pneus Industriels RemoulÉs M.b. Inc. 1375 Boulevard Charest Ouest, Local 5, Quebec, QC G1N 2E7
Service D'entretien Empro Inc. 16-1375 Rue Frank-carrel, Quebec, QC G1N 2E7
Corporation Énerblock Inc. 1375 Boulevard Charest Ouest, Local 5, Québec, QC G1N 2E7 2004-11-15
SystÈme De Transformation De Pneus S.t.p. Inc. 1375 Boulevard Charest Ouest, Local 5, Québec, QC G1N 2E7 2004-11-15
8512841 Canada Inc. 2020, Rue Cyrille-duquet, Québec, QC G1N 2E8 2013-05-03
4264690 Canada Inc. 2000 Rue Jean-talon Nord, Sainte-foy, QC G1N 2E8 2004-10-28
Lallier Automobile (quebec) Inc. 2000 Rue Jean Talon Nord, Quebec, QC G1N 2E8 1980-10-10
Lallier Automobile (quÉbec) Inc. 2000 Cyrille-duquet, Québec, QC G1N 2E8
9639918 Canada Inc. 2065, Rue Frank-carrel, Suite 210, Quebec, QC G1N 2G1 2016-02-22
Technologies Cognisco Inc. 207-2065, Rue Frank-carrel, Québec, QC G1N 2G1 2005-12-21
Block Distributions Inc. 2125 Jean Talon Sud, Sainte-foy (quebec), QC G1N 2G2 2004-02-04
Les Autobus Bussieres Ltee 2145, Jean Talon Sud, Ste-foy, QC G1N 2G2 2002-10-16
4065930 Canada Inc. 2125 Rue Jean-talon Sud, Sainte-foy, QC G1N 2G2 2002-05-15
3890881 Canada Inc. Rue Jean-talon Sud, Ste-foy, QC G1N 2G2 2001-04-26
9169067 Canada Inc. 2150 Cyrille-duquet, Bureau 100, Québec, QC G1N 2G3 2015-02-01
Lepage Signature Inc. 115 - 2100, Rue Cyrille-duquet, Quebec, QC G1N 2G3 2013-02-14
Artic Communication Incorporée 2160, Cyrille-duquet Local 195, Québec, QC G1N 2G3 2007-03-06
Innovation Nutaq Inc. 2150, Cyrille-duquet, Québec, QC G1N 2G3 2005-05-30
Bilodard Inc. 100-2150, Rue Cyrille-duquet, Québec, QC G1N 2G3 2001-01-10
3651231 Canada Inc. 2240 Jean-talon Nord, Ste-foy, QC G1N 2G3 1999-08-18
Innovation Nutaq Inc. 2150 Cyrille-duquet, Québec, QC G1N 2G3
Entreprises Courem Ltee 2300 Rue Cyrille-duquet, QuÉbec, QC G1N 2G5 1978-07-27
Coulombe Quebec Limitee 2300,cyrille-duquet, Quebec, QC G1N 2G5 1927-04-07
11887734 Canada Association 592 Rue Kirouac, Québec, QC G1N 2H8 2020-02-05
Votreespace Services Internet Inc. 766 Kirouac, Suite 267, QuÉbec, QC G1N 2J4 2008-06-03
4005015 Canada Inc. 710 Cote De La Pente Douce, Quebec, QC G1N 2M1 2002-02-20
Flash Tribu Inc. 551, Arago Ouest, Québec, QC G1N 2M4 2015-07-13
Naterra Bio-solutions Inc. 3630 Bois De ChÊne, QuÉbec, QC G1N 3B1 2002-06-10
Mv Capital Inc. 633#2 Bagot, Québec, QC G1N 3B3 2009-05-18
Les Editions Ciel D'images Inc. 19 Courcelette, Quebec, QC G1N 3B9 1991-05-07
6348645 Canada SociÉtÉ Par Actions De RÉgime FÉdÉral 616c St-vallier Ouest, QuÉbec, QC G1N 3C5 2005-02-11
4058267 Canada Inc. 915, Boul. Charest Ouest, Quebec, QC G1N 3C9 2002-04-29
Single Bracelet Entertainment Inc. 29 Rue Marie-de-l'incarnation, A, Québec, QC G1N 3E5 2016-02-12
9595864 Canada Inc. 25 Marie De L`incarnation, Québec, QC G1N 3E5 2016-01-22
9427406 Canada Inc. 29a, Rue Marie-de-l'incarnation, Québec, QC G1N 3E5 2015-09-02
7623631 Canada Inc. 230-01 Marie De L'incarnation, Québec, QC G1N 3G4 2012-12-04
7623640 Canada Inc. 230-01, Marie De L'incarnation, Québec, QC G1N 3G4 2012-12-04
MosquÉe De La Capitale 270 Rue Marie De L'incarnation, Quebec, QC G1N 3G4 2011-06-20
Immeubles Le 429 Caron Inc. 230, Rue Marie-de-l'incarnation, Appartement 1, Québec, QC G1N 3G4 2010-03-23
Centre Audiotech M.r. Inc. 355 Marie De L'incarnation, Quebec, QC G1N 3G9 1981-03-31
Cpu-memmart Inc. 210 Charest Est, Quebec City, QC G1N 3H1 1998-05-26
Pixelbuzz Inc. 258-1 Lafayette, Québec, QC G1N 3H6 2012-10-16
177587 Canada Inc. 727 Raoul-jobin, Québec, QC G1N 3H8 1977-03-02
10888249 Canada Inc. 364 Rue Lafayette, QuÉbec, QC G1N 3J1 2018-07-16
Mes-pmp Solutions Inc. 300 Rue Dieppe, Québec, QC G1N 3M8 2006-08-24
10502073 Canada Inc. 403, Rue Dieppe, Québec, QC G1N 3N2 2017-11-20
Imprimerie Ccl Ltée 403 Rue Dieppe, Quebec, QC G1N 3N2 1975-12-22
Imprimerie Ccl Ltée 403, Rue Dieppe, Québec, QC G1N 3N2