Canada · Corporation

Jurisdiction: Canada
Register: Corporations Canada

This dataset contains listing of 0.85m corporations incorporated with Corporations Canada, Innovation, Science and Economic Development Canada. Each corporation is registered with the following information: corporation number, corporate name, office address (street address, city, postal code), current status, governing legislation, directors, annual filling dates, etc.

H3B · Search Result

Corporation Name Office Address Incorporation
Le Groupe Lmb Experts-conseils Inc. 1010, Rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 500, Montreal, QC H3B 0A1
Mistior Inc. 1010 De La GauchetiÈre Ouest, Bureau 500, MontrÉal, QC H3B 0A1 2006-09-27
9332073 Canada Inc. 2500-1000 De La Gauchetière Street West, Montréal, QC H3B 0A2 2017-12-22
8504741 Canada Inc. 2500-1000 De La Gauchetière West, Montreal, QC H3B 0A2 2014-08-28
Plaza Des Seigneurs Holdings Inc. 100 De La Gauchètiere West, Suite 2500, Montréal, QC H3B 0A2 2011-12-22
Place Desormeaux Holdings Inc. 1000 De La Gauchetière West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2011-08-22
Monaxxion Enterprises Corporation 1000, De La Gauchetière Ouest, 24e étage, Montréal, QC H3B 0A2 2010-07-06
Planet Finance Canada 2500 - 1000 Rue De La Gauchetière Ouest, Montreal, QC H3B 0A2 2007-10-15
Savage Canac Corporation Suite 2500, 1000 Rue De La Gauchetiere O, Montreal, QC H3B 0A2 2004-04-23
2906864 Canada Inc. 1000, Rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 2500, Montreal, QC H3B 0A2 1993-03-26
Competitor Canada, Inc. 1000 Rue De La Gauchetière West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 1985-11-28
Conseillers Canaglobe Ltee 1000 De La Gauchtière St. West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 1977-08-24
Finlogik Inc. 1000 Rue De La Gauchtiere Ouest, Suite 2500, Montréal, QC H3B 0A2
Griflin Investments Inc. 1000 Rue De La GauchetiÈre Street West, Suite 2500, MontrÉal, QC H3B 0A2
2692660 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Sutie 2500, Montreal, QC H3B 0A2 1991-02-18
2705800 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 1991-04-09
2747901 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 1991-08-30
Ibi/daa Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 1993-02-04
3309568 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 1996-10-30
3382711 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, 2500, Montreal, QC H3B 0A2 1997-06-12
Equipements Ferroviaires Holland Ltee 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 1970-04-06
3116808 Canada Inc. 1000, Rue De La Gauchetière Ouest, 2500, Montréal, QC H3B 0A2 1995-02-09
France Telecom Canada Inc. 1000, Rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 2500, Montréal, QC H3B 0A2 1998-12-24
Egothera Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 1999-12-03
Gempire Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2500, MontrÉal, QC H3B 0A2 2001-11-20
Les Investissements Inca Cie. Ltee 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 1956-05-28
4012208 Canada Inc. 1000 Rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 2500, Montreal, QC H3B 0A2
Edward Jones Insurance Agency (quebec) Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2002-02-27
4362641 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière St. West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2006-08-21
4362659 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière St. West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2006-08-21
4362667 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière St. West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2006-08-21
4362675 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière St. West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2006-08-21
4362683 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière St. West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2006-08-21
Avdel Canada Limited 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2
Pfleiderer Canada Holding Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2006-12-19
Les Investissements Dione Appleton Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 1980-12-31
Investissements Plurax Inc. 1000 Rue De La Gauchetiere Ouest, Bureau 2500, Montreal, QC H3B 0A2 1981-10-22
Lectra Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montréal, QC H3B 0A2 1983-05-19
Flexart Design Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montréal, QC H3B 0A2 1985-11-28
Les Immeubles Benay Inc. 1000, Rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 2500, Montréal, QC H3B 0A2 1980-05-21
Le Festival De La SantÉ Inc. 1000 De La Gauchetière West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 1993-09-30
ChÂteau M.t. Inc. 1000, Rue De La Gauchetière Ouest, 2500, Montréal, QC H3B 0A2 1995-01-09
Alfalight Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2000-09-05
Canac Railway Services Inc. Suite 2500, 1000 Rue De La Gauchetiere O, Montreal, QC H3B 0A2 2001-03-06
Ics Triplex Isagraf Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 5300, Montreal, QC H3B 0A2 2002-12-02
Iwt Bio Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2003-11-14
4481747 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2008-12-10
4481763 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière St. West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2008-12-16
3424014 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere St. West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2
Ashburton Holdings Inc. 1000 De La GauchetiÈre St. West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2
Griflin Investments Inc. 1000 De La GauchetiÈre St. West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2
Les Immeubles Carrefour Claude-robutel Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montréal, QC H3B 0A2 2009-02-10
4542428 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere St. West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2009-12-17
4542436 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2
4542452 Canada Inc. 1000, Rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 2500, Montréal, QC H3B 0A2 2010-01-12
Targanta Therapeutics Inc. / Targanta Thérapeutiques Inc. 1000 Rue De La Gauchetière Ouest, Suite 2500, Montréal, QC H3B 0A2
4542436 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2
6759149 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2007-05-01
Nemaska Lithium Inc. 1000 Rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 2500, Montréal, QC H3B 0A2 2007-05-16
Score Aero Energy Limited 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2004-10-19
Xunlight Quebec Solar Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montréal, QC H3B 0A2 2008-07-18
Les Immeubles Carrefour Alexander Graham Bell Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montréal, QC H3B 0A2 2008-10-01
Innisfree Mcgill (holding) Inc. 1000 Rue De La Gauchetiere Ouest, # 2500 (m-067), Montreal, QC H3B 0A2 2010-04-07
Innisfree Mcgill (associé) Inc. 1000 Rue De La Gauchetière Ouest, #2500 (m-067), Montréal, QC H3B 0A2 2010-04-07
Digital Energy Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2010-06-02
7639007 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière St. West, Suite 2500, Montréal, QC H3B 0A2 2011-11-14
Stern Centre for Language and Learning Canada 1000 De La Gauchetiere Ouest, Bureau 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2011-10-14
8504695 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2013-11-22
8504709 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2013-11-22
8504717 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2013-11-22
8504873 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2015-07-14
8541973 Canada Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 2013-06-07
Ashburton Holdings Inc. 1000 De La Gauchetiere Street West, Suite 2500, MontrÉal, QC H3B 0A2
Association of Pdmsbr Restaurants Franchisees Bureau 2500, 1000, Rue De La Gauchetière Ouest, Montréal, QC H3B 0A2 2013-10-02
Technologies Ctspec Inc. 2500-1000 De La Gauchetiere West, Montreal, QC H3B 0A2
Rq Terminals Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montréal, QC H3B 0A2 2016-07-15
10002917 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montréal, QC H3B 0A2 2016-11-30
10267350 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière West, Suite 2500, Montréal, QC H3B 0A2 2017-06-06
10398829 Canada Inc. 1000, De La Gauchetière Ouest, Bureau 2500, Montréal, QC H3B 0A2 2017-09-08
Canbro Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2500, MontrÉal, QC H3B 0A2 1982-04-28
177840 Canada Inc. 1000, Rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 2500, MontrÉal, QC H3B 0A2 1984-04-24
10557102 Canada Inc. 2500-1000 De La Gauchetière Street West, Montréal, QC H3B 0A2 2017-12-27
10589772 Canada Inc. 1000 Rue De La Gauchetière West, Suite 2500, Montréal, QC H3B 0A2
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. Suite 2500, 1000 Rue De La Gauchetière Ouest, Montréal, QC H3B 0A2 2018-05-07
Jitneytrade Inc. 1000 Rue De La Gauchetière Ouest, Suite 2500, Montréal, QC H3B 0A2
11407414 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montréal, QC H3B 0A2 2019-05-13
11849573 Canada Inc. 2500-1000 De La Gauchetière Street West, Montréal, QC H3B 0A2 2020-01-17
11852604 Canada Inc. 2500-1000 De La Gauchetière Street West, Montréal, QC H3B 0A2 2020-01-20
Tidal Health Solutions Ltd. 1000 Rue De La Gauchetière, Bureau 2500, Montréal, QC H3B 0A2
11885022 Canada Inc. 2500-1000 De La Gauchetière Street West, Montréal, QC H3B 0A2 2020-02-04
11885057 Canada Inc. 2500-1000 De La Gauchetière Street West, Montréal, QC H3B 0A2 2020-02-04
Bentley Motors Canada, Ltd. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2
Gestas (1995) Inc. 700 De La Gauchetiere Ouest, Bureau 1600, Montreal, QC H3B 0A4 1995-11-22
Minet Inc. 700 De La GauchetiÈre Street West, Suite 1800, Montreal, QC H3B 0A5
7865171 Canada Inc. 150 Chemin De La Pointe Sud, Unit 1107, Verdun, QC H3B 0A7 2011-05-16
Services Financiers Valeurs MobiliÈres Desjardins Inc. 1170, Rue Peel, Bur. 300, MontrÉal, QC H3B 0A9 2006-04-25
Desjardins Securities International Inc. 1170 Rue Peel, Bureau 300, Montreal, QC H3B 0A9 2001-01-24
Gestion Vmd Inc. 1170, Rue Peel, Bur. 300, MontrÉal, QC H3B 0A9 2004-11-18
8031843 Canada Inc. 1170, Rue Peel, Bureau 300, Montréal, QC H3B 0A9 2013-03-07
Desjardins Securities Inc. 1170 Rue Peel, Bureau 300, Montreal, QC H3B 0A9 1982-03-24