Canada · Corporation

Jurisdiction: Canada
Register: Corporations Canada

This dataset contains listing of 0.85m corporations incorporated with Corporations Canada, Innovation, Science and Economic Development Canada. Each corporation is registered with the following information: corporation number, corporate name, office address (street address, city, postal code), current status, governing legislation, directors, annual filling dates, etc.

H3B 4W5 · Search Result

Corporation Name Office Address Incorporation
11985841 Canada Inc. 1000 Rue De La Gauchetière O, Suite 2400, Montréal, QC H3B 4W5 2020-03-31
Rein360 Inc. 3700-1000 De La Gauchetière West, Montréal, QC H3B 4W5 2019-07-19
11499319 Canada Corp. 200-1000 De La Gauchetiere Street West, Montreal, QC H3B 4W5 2019-07-05
Barsktage Inc. 24-1000 Rue De La Gauchetière Ouest, Montréal, QC H3B 4W5 2019-05-06
11323075 Canada Inc. App 2448, 1000 Rue De La Gauchetière Ouest, Montréal, QC H3B 4W5 2019-03-27
11188291 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere O, Suite 1200, Montréal, QC H3B 4W5 2019-01-09
11180886 Canada Inc. 3700-1000 Rue De La Gauchetière West, Montréal, QC H3B 4W5 2019-01-07
Canadian International Investment Management Ltd. 1000 Rue De La Gauchetière O, 2456, Montréal, QC H3B 4W5 2018-08-09
Fonds Cgc - Cgc Fund 3500 - 1000 Rue De La Gauchetière Ouest, Montreal, QC H3B 4W5 2017-11-09
Institut Nova Gallia 2900-1000, Rue De La Gauchetière O., Montréal, QC H3B 4W5 2017-02-07
Canadian Opportunities Real Assets Inc. 2900-1000 De La Gauchetière West, Montreal, QC H3B 4W5 2016-06-10
Blackbird Capital Inc. 3500-1000 De La Gauchetiere Street West, Montreal, QC H3B 4W5 2015-10-23
Acadian Pe Supreme Inc. 3700-1000 De La Gauchetière Ouest, Montreal, QC H3B 4W5 2015-09-18
9423125 Canada Inc. 200-1000, Rue De La Gauchetière Ouest, Montréal, QC H3B 4W5 2015-08-28
9357998 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière W, 24th Floor, Montreal, QC H3B 4W5 2015-07-06
Agence Dicovia Inc. 2400-1000, Rue De La GauchetiÈre O., MontrÉal, QC H3B 4W5 2014-09-25
Kija Invest & Trade Inc. 200-1000 De La Gauchetiere, Montréal, QC H3B 4W5 2014-02-14
8647798 Canada Inc. 4300-1000 De La Gauchetière Street West, Montreal, QC H3B 4W5 2013-10-01
Enteracc Technologies Inc. 3700-1000 De La Gauchetière Street West, Montréal, QC H3B 4W5 2013-09-18
Transit Bd Inc. 4300-1000 Rue De La Gauchetière Ouest, Montréal, QC H3B 4W5 2013-09-13
Foti Group Inc. 1000 De La Gauchetiere St. O., Suite 2400, Montreal, QC H3B 4W5 2013-03-13
Bep Gso Inc. 2400-1000 De La Gauchetiere West, Montreal, QC H3B 4W5 2013-03-06
8207275 Canada Inc. 1,000 De La Gauchetiere W., Suite 2900, Montreal, QC H3B 4W5 2012-12-04
Little Big Job Networks Inc. 3700 - 1000 Rue De La Gauchetière Ouest, Montréal, QC H3B 4W5 2012-02-06
Toron Resources Inc. 1000 29th Floor, De La Gauchetiere St. West, Montreal, QC H3B 4W5 2011-09-15
Corporation D'Évaluation Et Recouvrement De CrÉdit Erc 1000 De La Gauchetière West,, Suite 2900, Montréal, QC H3B 4W5 2011-09-06
Wacoal Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Blvd. West, Suite 2400, Montreal, QC H3B 4W5 2011-05-06
7591675 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière, Suite# 2400, Montréal, QC H3B 4W5 2010-07-05
Allexium Gestion D'actifs Inc. 1000 Rue De La Gauchetière, Suite 2400, Montreal, QC H3B 4W5 2010-05-11
Hush Studios Inc. 2900-1000 De La Chauchetière West, Montreal, QC H3B 4W5 2010-01-19
7290730 Canada Inc. 4300 - 1000 Rue De La Gauchetière Ouest, Montréal, QC H3B 4W5 2009-12-04
Perigen (canada) Ltd. 2100 - 1000 De La Gauchetière Street We, Montréal, QC H3B 4W5 2009-07-16
Dwt Capital Inc. Suite 3500-1000 De La Gauchetière West, Montreal, QC H3B 4W5 2009-05-19
7171536 Canada Inc. 7171536, Suite 2400, Montreal, QC H3B 4W5 2009-05-11
7164068 Canada Inc. 1000, De La Gauchetière, Bureau 1500, Montréal, QC H3B 4W5 2009-04-27
Locations Freedom Spirit Inc. 2400 - 1000 De La Gauchetière Ouest, Montréal, QC H3B 4W5 2009-04-16
Youth Action International - Canada 1000 Rue De La Gauchetiere Ouest, Bureau 2900, Montreal, QC H3B 4W5 2009-03-26
Acces Consultants Management Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Ouest Suite 2400, Montréal, QC H3B 4W5 2008-07-29
Qualiti7 Inc. 1000 Rue De Lagauchetière Ouest, Suite 2400, Montréal, QC H3B 4W5 2008-06-19
4423658 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière, Suite 2900, Montreal, QC H3B 4W5 2008-03-03
4453069 Canada Inc. 1205 - 1000 De La Gauchetiere W, Montreal, QC H3B 4W5 2007-11-27
Samaritan Therapeutics Inc. 1000 De La Gauchetière West Suite 2400, Montréal, QC H3B 4W5 2007-05-22
Avance Solutions Experts (ase) Inc. 3700 - 1000 De La Gauchetière Ouest, Montreal, QC H3B 4W5 2006-12-15
4382048 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere Street W., Suite 2900, Montreal, QC H3B 4W5 2006-08-29
Les Placements ElysÉe Inc. 1000, De La Gauchetiere West, Suite 200, Montreal, QC H3B 4W5 2006-06-01
Mnc Capital One Inc. 1000, De La Gauchetière Street West, Suite 2900, Montréal, QC H3B 4W5 2006-02-17
6467032 Canada Inc. 439 University Av, Suite 500, Toronto, QC H3B 4W5 2005-11-01
4313291 Canada Inc. 1000, Rue De La Gauchetière Ouest #2900, Montréal, QC H3B 4W5 2005-10-20
6421601 Canada Inc. 1000 Rue De La Gauchetière, Suite 3700, Montréal, QC H3B 4W5 2005-07-21
Polar Electro Canada Inc. 3700 - 1000 De La Gauchetière West, Montréal, QC H3B 4W5 2004-07-29
4223136 Canada Inc. 1000rue De La Gauchetiere, Suite, Montreal, QC H3B 4W5 2004-02-24
Air Class International Airlines, Ltd. 1000 De La GauchetiÈre #24, Montreal, QC H3B 4W5 2003-10-30
4178963 Canada Inc. 200-1000, De La Gauchetière O., Montréal, QC H3B 4W5 2003-07-23
Shawa Group International (sgi) Capital Canada Corp. 1000, Rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 2900, Montreal, QC H3B 4W5 2002-02-21
Betty Bytes Inc. 1000 De La GauchetiÈre West, Suite 2900, Montreal, QC H3B 4W5 2002-02-12
4010221 Canada Inc. 1000 De La GauchetiÈre Ouest #2900, MontrÉal, QC H3B 4W5 2002-02-04
Greg Chamandy Holdings Inc. 3700-1000, Rue De La Gauchetière Ouest, Montréal, QC H3B 4W5 2001-11-02
3880885 Canada Inc. 1000 De La GauchetiÈre Ouest, Suite 2900, MontrÉal, QC H3B 4W5 2001-04-02
3743411 Canada Inc. 1000 De La ChaudiÈre Street West, Suite 2600, Montreal, QC H3B 4W5 2000-05-04
Stock Keeping Units (sku) International Inc. 1000, De La Gauchetière, Suite 1500, Montreal, QC H3B 4W5 1999-07-16
Le Fonds De Dotation De Les Grands Ballets Canadiens Suite 3500, 1000 De La Gauchetiere Ouest, Motnreal, QC H3B 4W5 1999-03-26
3562808 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere St.west, Suite 3500, Montreal, QC H3B 4W5 1999-03-16
Women's International Shipping and Trading Association - Wista Canada Inc.- 1000, De La Gauchetiere Ouest, Bureau 3500, Montreal, QC H3B 4W5 1998-11-02
Gestion Gpb Beaudoin (1998) Inc. 1000 Rue De La Gauchetiere Ouest, Suite 4300, Montreal, QC H3B 4W5 1998-07-10
3441601 Canada Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 1997-12-03
Generix Group North America Inc. 2100 - 1000 Rue De La Gauthetière Ouest, MontrÉal, QC H3B 4W5 1997-10-30
Les Investissements Larry Karpman Inc. 2455, Place Lafortune W., Saint-laurent, QC H3B 4W5 1995-11-09
2910748 Canada Ltd. 3500-1000 De La GauchetiÈre Ouest, Montreal, QC H3B 4W5 1993-04-07
2880539 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere Ouest, Bureau 320, Montreal, QC H3B 4W5 1992-12-22
Enerpap Inc. 1000 De La Gauchetiere Street, West, Montreal, QC H3B 4W5 1992-08-11
Talvestco Inc. 1000 Rue De La Gauchetiere O., Bureau 3200, Montreal, QC H3B 4W5 1991-09-11
Investissements Pierpointe Inc. 2600-1000 De La Gauchetiere W, Montreal, QC H3B 4W5 1985-02-08
Cida Conseiller Informatique David Ahdoot Inc. 3700-1000 Rue De La Gauchetière Ouest, Montréal, QC H3B 4W5 1981-08-28
107082 Canada Ltee 888 3rd St 10th Floor, West Tower, Calgary Alberta, QC H3B 4W5 1981-06-05
Frachades Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 1979-09-26
Melaro Investments Ltd. 650-1000, De La Gauchetière Street West, Montreal, QC H3B 4W5 1979-08-29
Manalex Management Ltd. - 1000 Rue De La Gauchetiere Oeust, Bureau 2900, Montreal, QC H3B 4W5 1975-04-25
Per Hall Associes Ltee 900-1000 De La Gauchetière West, Montréal, QC H3B 4W5 1968-04-09
120832 Canada Inc. 2700 -1000 De La Gauchetiere West, (canada Trust), Montreal, QC H3B 4W5 1957-04-11
2992957 Canada Inc. 1000 Rue De La Gauchetiere O., Bureau 200, Montreal, QC H3B 4W5
Berkson Holdings Ltd. 2600-1000 De La Gauchetiere West, Montreal, QC H3B 4W5
Donner Metals Ltd. 2100-1000 De La Gauchetière Ouest, Montreal, QC H3B 4W5
10167045 Canada Inc. 2100 - 1000 Rue De La Gauchetiere, Montreal, QC H3B 4W5
Thompson Wood Products Inc. 2700-1000 De La Gauchetiere West, Montreal, QC H3B 4W5
C-mac Microcircuits Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 1990-12-19
C-mac Interconnect Products Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2100, MontrÉal, QC H3B 4W5 1990-12-19
Honeywell Aube Technologies Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 1991-01-15
152248 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere West, 9th Floor, Montreal, QC H3B 4W5 1986-10-08
C-mac of America, Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 1991-11-12
Auberge West Brome (condos) Inc. 1000 De La Gauchetiere West, Suite 3500, Montreal, QC H3B 4W5 1992-01-20
2867541 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 1992-11-10
2867559 Canada Inc. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5 1992-11-10
Jeans Edwin Canada, LtÉe 1000 De La Gauchetiere West, Suite2900, Montreal, QC H3B 4W5 1996-02-19
Cie De Manufacture Edwin, LtÉe 1000 De La Gauchetiere West, Suite 2900, Montreal, QC H3B 4W5 1996-02-23
2856557 Canada Inc. 1000 De La Gauchetiere West, Suite 2900, Montreal, QC H3B 4W5
Lg Technologies Group Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 1996-04-10
Biotronix 2000 Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2100, Montreal, QC H3B 4W5 1996-10-16
Investissements Israel Engel Inc. 1000 De La GauchetiÈre Street West, Suite 2600, Montreal, QC H3B 4W5
Doggie Merlin Holdings Inc. 1000 De La Gauchetiere, Suite 900, Montreal, QC H3B 4W5 1996-12-13
Talvest (lsvc) Inc. 1000 De La Gauchetiere West, Suite 3200, Montreal, QC H3B 4W5 1996-12-18