PLACEMENTS TMS INC.

Address:
1010 Rue De La GauchetiÈre Ouest, Bureau 600, MontrÉal, QC H3B 2N2

PLACEMENTS TMS INC. is a business entity registered at Corporations Canada, with entity identifier is 4400623. The registration start date is January 1, 1970. The current status is Inactive - Amalgamated.

Corporation Overview

Corporation ID 4400623
Business Number 135432383
Corporation Name PLACEMENTS TMS INC.
Registered Office Address 1010 Rue De La GauchetiÈre Ouest
Bureau 600
MontrÉal
QC H3B 2N2
Corporation Status Inactive - Amalgamated / Inactif - Fusionnée
Number of Directors 1 - 10

Directors

Director Name Director Address
SERGE SAVARD 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, #600, MONTRÉAL QC H3B 2N2, Canada
MARIO MESSIER 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, #600, MONTRÉAL QC H3B 2N2, Canada
BERNARD THIBAULT 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, #600, MONTRÉAL QC H3B 2N2, Canada

Corporation History

Type Effective Date Expiry Date Detail
Act 2007-01-01 current Canada Business Corporations Act (CBCA)
Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA)
Address 2007-01-01 current 1010 Rue De La GauchetiÈre Ouest, Bureau 600, MontrÉal, QC H3B 2N2
Name 2011-10-14 current PLACEMENTS TMS INC.
Name 2007-01-01 2011-10-14 THIBAULT, MESSIER, SAVARD ET ASSOCIÉS INC.
Status 2013-01-01 current Inactive - Amalgamated / Inactif - Fusionnée
Status 2007-01-01 2013-01-01 Active / Actif

Activities

Date Activity Details
2011-10-14 Amendment / Modification Name Changed.
Section: 178
2011-06-23 Amendment / Modification Section: 178
2007-01-01 Amalgamation / Fusion Amalgamating Corporation: 3398731.
Section:
2007-01-01 Amalgamation / Fusion Amalgamating Corporation: 3574342.
Section:
2007-01-01 Amalgamation / Fusion Amalgamating Corporation: 3849058.
Section:
2007-01-01 Amalgamation / Fusion Amalgamating Corporation: 4211081.
Section:

Annual Returns Filings

Year Annual Meeting Date Corporation Type
2012 2011-06-22 Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders
Société n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins
2011 2010-04-01 Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders
Société n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins
2010 2009-03-20 Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders
Société n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins

Office Location

Address 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST
City MONTRÉAL
Province QC
Postal Code H3B 2N2
Country Canada

Corporations in the same location

Corporation Name Office Address Incorporation
Gestions Michael Shapiro Inc. 1010 Rue De La Gauchetière Ouest, Suite 600, Montréal, QC H3B 2N2 1992-01-31
3486486 Canada Inc. 1010 Rue De La Gauchetiere Ouest, Bur. 1230, Montreal, QC H3B 2N2 2000-02-24
3521672 Canada Inc. 1010 Rue De La GauchetiÈre Ouest, Bureau 1230, Montreal, QC H3B 2N2 2000-02-24
3587541 Canada Inc. 1010 Rue De La Gauchetière Ouest, Suite 600, Montréal, QC H3B 2N2 1999-04-29
3587568 Canada Inc. 1010 Rue De La Gauchetière Ouest, Suite 600, Montréal, QC H3B 2N2 1999-04-29
Mondial Des Jeux Et Sports Traditionnels 1010 Rue De La Gauchetiere Ouest, Bureau 1400, Montreal, QC H3B 2N2 1999-07-22
Football Montréal 2001 1010 Rue De La Gauchetiere Ouest, Bureau 1400, Montreal, QC H3B 2N2 1999-07-22
3653242 Canada Inc. 1010 Rue De La GauchetiÈre Ouest, Bureau 1230, Montreal, QC H3B 2N2 1999-11-15
Services Financiers C.t.q. Inc. 1010 Rue De La GauchetiÈre Ouest, Bureau 1325, Montreal, QC H3B 2N2 1999-11-23
3712885 Canada Inc. 1010 Rue De La GauchetiÈre Ouest, Bureau 1230, Montreal, QC H3B 2N2 2000-01-17
Find all corporations in the same location

Corporations in the same postal code

Corporation Name Office Address Incorporation
Cannabis Quality Assurance (cqa) Inc. 950-1010 Rue De La Gauchetière West, Montréal, QC H3B 2N2 2019-03-06
Evofun Inc. 950-1010 Rue De La Gauchetière Ouest, Montréal, QC H3B 2N2 2019-01-25
10863335 Canada Inc. 1020-1010 De La Gauchetière Street West, Montréal, QC H3B 2N2 2018-06-28
Digital Nomad Analytics Inc. 200-1010 Rue De La Gauchetière O, Montreal, QC H3B 2N2 2017-05-04
9993819 Canada Inc. 1010 De La Gauchetiere W., Suite 1315, Montreal (ville-marie), QC H3B 2N2 2016-11-22
9992049 Canada Inc. 1020-1010 Rue De La Gauchetière O, Montréal, QC H3B 2N2 2016-11-21
9727744 Canada Inc. 1020-1010 De La Gauchetière St W., Montréal, QC H3B 2N2 2016-04-27
9155830 Canada Inc. 1010, De La Gauchetière Street West, Suite 1020, Montreal, QC H3B 2N2 2015-01-16
9062467 Canada Inc. 1010 De La Gauchetière W, Suite 1230, Montréal, QC H3B 2N2 2014-10-24
8791732 Canada Inc. 1010 De La Gauchetiere Street West, 1020, Montreal, QC H3B 2N2 2014-06-04
Find all corporations in postal code H3B 2N2

Corporation Directors

Name Address
SERGE SAVARD 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, #600, MONTRÉAL QC H3B 2N2, Canada
MARIO MESSIER 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, #600, MONTRÉAL QC H3B 2N2, Canada
BERNARD THIBAULT 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, #600, MONTRÉAL QC H3B 2N2, Canada

Entities with the same directors

Name Director Name Director Address
12361396 Canada Inc. Bernard Thibault PH1-1425, avenue du Docteur-Penfield, Montréal QC H3G 2V1, Canada
TGTA INC. BERNARD THIBAULT 1425 Docteur-Penfield, app. PH1, Montréal QC H3G 2V1, Canada
PROJET TMS EDGE WP INC. Bernard Thibault 1425 avenue du Docteur-Penfield, PH1, Montréal QC H3G 2V1, Canada
THIBAULT, MESSIER, SAVARD ET ASSOCIÉS INC. BERNARD THIBAULT PH1-1425, avenue du Docteur-Penfield, Montréal QC H3G 2V1, Canada
TMS QUARTIER DU PARC II INC. Bernard Thibault 1425 Avenue Dr. Penfield, App. PH 1, Montréal QC H3G 2V1, Canada
125544 CANADA INC. BERNARD THIBAULT 1291 RUE DES HIRONDELLES, LONGUEUIL QC J4G 1W8, Canada
8317763 CANADA INC. Bernard Thibault 1425 du Docteur-Penfield, PH1, Montréal QC H3G 2V1, Canada
4330650 CANADA INC. BERNARD THIBAULT 1425 AVENUE DU DOCTEUR-PENFIELD, APP. PH-1, MONTRÉAL QC H3G 2V1, Canada
8842124 CANADA INC. Bernard Thibault 1425 av. du Docteur-Penfield, PH1, Montréal QC H3G 2V1, Canada
ACCOMODATION BERNARD THIBAULT LTEE BERNARD THIBAULT 1128 CHEMIN DU VILLAGE, COATICOOK QC J1A 2S5, Canada

Competitor

Search similar business entities

City MONTRÉAL
Post Code H3B 2N2

Similar businesses

Corporation Name Office Address Incorporation
L.u.a.g. Services De Placements Orientale Inc. 5845 Cote Des Neiges, Suite 220, Montreal, QC H3S 1Z4 1987-09-09
Placements Gohier Limited 3333 Jarry East, Montreal 38, QC 1951-04-21
Placements B. Allard Inc. 6500 Chemin De La Savane, Saint-hubert, QC J3Y 8Y9
Les Placements Guy Duhaime Inc. 4860 Rue Jacques-cartier, Saint-hyacinthe, QC J2S 8A3
Les Placements Pijaro Inc. 975, Boulevard Saint-joseph, Gatineau, QC J8Z 1W8
Les Placements Bernard Lalancette Inc. 4567, Chemin Saint--andrÉ, Saguenay (jonquiÈre), QC G7X 7V4
Placements Pierre Latendresse Inc. 101, Chemin De St. Francis Wood, Magog, QC J1X 0M7
Les Placements RiviÈre Gatineau IncorporÉe 768, Boul. Saint-joseph, Bureau 100, Gatineau, QC J8Y 4B8
Placements S.a.f.c.i. Inc. 42 18 E Rue, St-georges, QC G5Y 4T1 1981-03-30
Placements Phd Inc. 841, Rue Cherrier, Montréal, QC H2L 1H6 2012-04-25

Improve Information

Please provide details on PLACEMENTS TMS INC. by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Corporations Canada
Jurisdiction Canada
Website www.ic.gc.ca
Entity Count 846524

Trending Searches