LES DÉVELOPPEMENTS TMSA 2011 INC.

Address:
1010, De La GauchetiÈre Ouest, Bureau 600, MontrÉal, QC H3B 2N2

LES DÉVELOPPEMENTS TMSA 2011 INC. is a business entity registered at Corporations Canada, with entity identifier is 6082378. The registration start date is April 2, 2003. The current status is Inactive - Amalgamated.

Corporation Overview

Corporation ID 6082378
Business Number 893993907
Corporation Name LES DÉVELOPPEMENTS TMSA 2011 INC.
Registered Office Address 1010, De La GauchetiÈre Ouest
Bureau 600
MontrÉal
QC H3B 2N2
Incorporation Date 2003-04-02
Corporation Status Inactive - Amalgamated / Inactif - Fusionnée
Number of Directors 1 - 10

Directors

Director Name Director Address
GUY TRUDEAU 2, 34E AVENUE, MONTRÉAL QC H1A 4M2, Canada
MARIO MESSIER 1956, ALFRED-PELLAN, LONGUEUIL QC J4N 1P6, Canada
BERNARD THIBAULT 1425, AVENUE DR. PENFIELD PH 1, MONTRÉAL QC H3G 2V1, Canada
MARTIN GALARNEAU 716 AV. BLOOMFIELD, MONTRÉAL QC H2V 3S3, Canada

Corporation History

Type Effective Date Expiry Date Detail
Act 2003-04-02 current Canada Business Corporations Act (CBCA)
Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA)
Address 2003-04-02 current 1010, De La GauchetiÈre Ouest, Bureau 600, MontrÉal, QC H3B 2N2
Name 2011-06-08 current LES DÉVELOPPEMENTS TMSA 2011 INC.
Name 2008-02-29 2011-06-08 LES DÉVELOPPEMENTS DESDEV INC.
Name 2007-11-20 2008-02-29 Les Développements TMSA inc.
Name 2003-04-02 2007-11-19 Société Immobilière TMST inc.
Status 2014-01-01 current Inactive - Amalgamated / Inactif - Fusionnée
Status 2003-04-02 2014-01-01 Active / Actif

Activities

Date Activity Details
2011-06-08 Amendment / Modification Name Changed.
Section: 178
2008-02-29 Amendment / Modification Name Changed.
2007-11-19 Amendment / Modification Name Changed.
2005-09-26 Amendment / Modification
2003-04-02 Incorporation / Constitution en société

Annual Returns Filings

Year Annual Meeting Date Corporation Type
2013 2012-05-11 Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders
Société n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins
2012 2011-03-11 Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders
Société n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins
2011 2010-03-01 Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders
Société n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins

Office Location

Address 1010, DE LA GAUCHETIÈRE OUEST
City MONTRÉAL
Province QC
Postal Code H3B 2N2
Country Canada

Corporations in the same location

Corporation Name Office Address Incorporation
Boutique Animex Mlt. Inc. 1010, De La Gauchetiere Ouest, Bureau 950, MontrÉal, QC H3B 2M2 1992-09-25
Les Developpements Natco Ltee 1010, De La GauchetiÈre Ouest, Bureau 600, MontrÉal, QC H3B 2N2
Les Systemes Interactifs Nextel Inc. 1010, De La GauchetiÈre Ouest, Suite 1020, MontrÉal, QC H3B 2N2 1989-12-08
Novipro Inc. 1010, De La GauchetiÈre Ouest, Bureau 1900, Montreal, QC H3A 1V4 1993-08-18
Tms Brossard Inc. 1010, De La Gauchetière Ouest, Bureau 600, Montréal, QC H3B 2N2 2005-12-31
Liveroot Corporation 1010, De La Gauchetière Ouest, Bureau 1230, Montréal, QC H3B 2N2 2006-01-09

Corporations in the same postal code

Corporation Name Office Address Incorporation
Cannabis Quality Assurance (cqa) Inc. 950-1010 Rue De La Gauchetière West, Montréal, QC H3B 2N2 2019-03-06
Evofun Inc. 950-1010 Rue De La Gauchetière Ouest, Montréal, QC H3B 2N2 2019-01-25
10863335 Canada Inc. 1020-1010 De La Gauchetière Street West, Montréal, QC H3B 2N2 2018-06-28
Digital Nomad Analytics Inc. 200-1010 Rue De La Gauchetière O, Montreal, QC H3B 2N2 2017-05-04
9993819 Canada Inc. 1010 De La Gauchetiere W., Suite 1315, Montreal (ville-marie), QC H3B 2N2 2016-11-22
9992049 Canada Inc. 1020-1010 Rue De La Gauchetière O, Montréal, QC H3B 2N2 2016-11-21
9727744 Canada Inc. 1020-1010 De La Gauchetière St W., Montréal, QC H3B 2N2 2016-04-27
9155830 Canada Inc. 1010, De La Gauchetière Street West, Suite 1020, Montreal, QC H3B 2N2 2015-01-16
9062467 Canada Inc. 1010 De La Gauchetière W, Suite 1230, Montréal, QC H3B 2N2 2014-10-24
8791732 Canada Inc. 1010 De La Gauchetiere Street West, 1020, Montreal, QC H3B 2N2 2014-06-04
Find all corporations in postal code H3B 2N2

Corporation Directors

Name Address
GUY TRUDEAU 2, 34E AVENUE, MONTRÉAL QC H1A 4M2, Canada
MARIO MESSIER 1956, ALFRED-PELLAN, LONGUEUIL QC J4N 1P6, Canada
BERNARD THIBAULT 1425, AVENUE DR. PENFIELD PH 1, MONTRÉAL QC H3G 2V1, Canada
MARTIN GALARNEAU 716 AV. BLOOMFIELD, MONTRÉAL QC H2V 3S3, Canada

Entities with the same directors

Name Director Name Director Address
12361396 Canada Inc. Bernard Thibault PH1-1425, avenue du Docteur-Penfield, Montréal QC H3G 2V1, Canada
TGTA INC. BERNARD THIBAULT 1425 Docteur-Penfield, app. PH1, Montréal QC H3G 2V1, Canada
PROJET TMS EDGE WP INC. Bernard Thibault 1425 avenue du Docteur-Penfield, PH1, Montréal QC H3G 2V1, Canada
THIBAULT, MESSIER, SAVARD ET ASSOCIÉS INC. BERNARD THIBAULT PH1-1425, avenue du Docteur-Penfield, Montréal QC H3G 2V1, Canada
TMS QUARTIER DU PARC II INC. Bernard Thibault 1425 Avenue Dr. Penfield, App. PH 1, Montréal QC H3G 2V1, Canada
125544 CANADA INC. BERNARD THIBAULT 1291 RUE DES HIRONDELLES, LONGUEUIL QC J4G 1W8, Canada
8317763 CANADA INC. Bernard Thibault 1425 du Docteur-Penfield, PH1, Montréal QC H3G 2V1, Canada
4330650 CANADA INC. BERNARD THIBAULT 1425 AVENUE DU DOCTEUR-PENFIELD, APP. PH-1, MONTRÉAL QC H3G 2V1, Canada
8842124 CANADA INC. Bernard Thibault 1425 av. du Docteur-Penfield, PH1, Montréal QC H3G 2V1, Canada
ACCOMODATION BERNARD THIBAULT LTEE BERNARD THIBAULT 1128 CHEMIN DU VILLAGE, COATICOOK QC J1A 2S5, Canada

Competitor

Search similar business entities

City MONTRÉAL
Post Code H3B 2N2

Similar businesses

Corporation Name Office Address Incorporation
Simplicity Developments 2011 Inc. 66 Iona Street, Ottawa, ON K1Y 3L8 2011-11-22
Groupe Tmsa Inc. 1010 De La GauchetiÈre Ouest, Bureau 600, MontrÉal, QC H3B 2N2 2008-04-14
Women's Congress 2011 120 University Pvt., Fss 5043, Ottawa, ON K1N 6N5 2008-04-14
General Woods & Veneers (2011) Ltd. 1458 Crescent Street, Montréal, QC H3G 2B6 1940-07-16
K.p. Underwriters (2011) Inc. (p.o.) Box 1830, Kahnawake, QC J0L 1B0 2011-10-13
Northern Precious Metals 2011 Inc. 1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, QC H3B 4M4 2011-02-23
Tuyaux De BÉton QuÉbec (2011) Inc. 1 Place Ville Marie, Bureau 2500, Montreal, QC H3B 1R1 2011-01-01
Emergency First Aid Products (2011) Inc. 700 Lebeau Blvd., Saint-laurent, QC H4N 1R5 2011-04-07
Analys Psychologie Organisationnelle (2011) Inc. 46 Rue Le Royer Ouest, Montréal, QC H2Y 1W7 2011-04-27
Les PropriÉtÉs Brunswick 2011 Inc. 8760 Pascal Gagnon Street, Montreal, QC H1P 1Z3 2011-07-04

Improve Information

Please provide details on LES DÉVELOPPEMENTS TMSA 2011 INC. by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Corporations Canada
Jurisdiction Canada
Website www.ic.gc.ca
Entity Count 846524

Trending Searches